-
DEVONSHIRE POINT LIMITED - 4th Floor Allan House, 10 John Princes Street, London, W1G 0AH, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08907134
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 4th Floor Allan House
- 10 John Princes Street
- London
- W1G 0AH 4th Floor Allan House, 10 John Princes Street, London, W1G 0AH UK
Management
- Geschäftsführung
- GUDKA, Manish Mansukhlal
- JONES, Gareth
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 21.02.2014
- Gelöscht am:
- 2020-03-12
- SIC/NACE
- 70100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Devonshire Point Investment S.A.R.L
- Devonshire Point Group Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Ehemalige Namen
- ROCK BIDCO LIMITED
- Rechtsträger-Kennung (LEI)
- 2138002ISVEVQ3TV9G86
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit:
- Letzte Einreichung: 2017-01-01
-
DEVONSHIRE POINT LIMITED Firmenbeschreibung
- DEVONSHIRE POINT LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08907134. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 21.02.2014 registriert. DEVONSHIRE POINT LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen ROCK BIDCO LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "70100" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über 4Th Floor Allan House erreicht werden.
Jetzt sichern DEVONSHIRE POINT LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Devonshire Point Limited - 4th Floor Allan House, 10 John Princes Street, London, W1G 0AH, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu DEVONSHIRE POINT LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
gazette-dissolved-liquidation (2020-03-12) - GAZ2
keyboard_arrow_right 2019
-
mortgage-satisfy-charge-full (2019-09-06) - MR04
-
liquidation-voluntary-members-return-of-final-meeting (2019-12-12) - LIQ13
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2019-11-23) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2018
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-10-19) - AD01
-
capital-allotment-shares (2018-01-16) - SH01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-03-07) - CS01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2018-04-04) - MR04
-
resolution (2018-04-30) - RESOLUTIONS
-
legacy (2018-04-30) - CAP-SS
-
legacy (2018-04-30) - SH20
-
resolution (2018-10-15) - RESOLUTIONS
-
liquidation-voluntary-declaration-of-solvency (2018-10-15) - LIQ01
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2018-10-15) - 600
-
capital-statement-capital-company-with-date-currency-figure (2018-04-30) - SH19
keyboard_arrow_right 2017
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-10-03) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-10) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-full (2017-04-20) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-10-03) - MR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-10-03) - AP01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-10-05) - MR01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2017-10-05) - MR04
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-10-03) - AD01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-12-21) - MR01
keyboard_arrow_right 2016
-
capital-allotment-shares (2016-08-03) - SH01
-
accounts-with-accounts-type-full (2016-08-10) - AA
-
capital-alter-shares-consolidation (2016-07-20) - SH02
-
resolution (2016-07-19) - RESOLUTIONS
-
mortgage-satisfy-charge-full (2016-04-20) - MR04
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-01) - AR01
-
resolution (2016-07-13) - RESOLUTIONS
-
legacy (2016-07-13) - CAP-SS
-
capital-statement-capital-company-with-date-currency-figure (2016-07-13) - SH19
-
legacy (2016-07-13) - SH20
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-04-20) - MR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-full (2015-07-06) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-05-11) - AR01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2015-05-11) - AA01
keyboard_arrow_right 2014
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2014-05-29) - MR01
-
certificate-change-of-name-company (2014-02-26) - CERTNM
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-03-25) - AP01
-
capital-allotment-shares (2014-04-15) - SH01
-
resolution (2014-05-22) - RESOLUTIONS
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2014-06-03) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2014-11-13) - MR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-10-22) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-10-23) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-10-23) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-10-31) - AP01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2014-11-26) - AA01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-10-22) - AP01
-
incorporation-company (2014-02-21) - NEWINC