-
GENTILI UNITED KINGDOM LIMITED - Gentili United Kingdom Limited Fairway, Off Delta Way, Bridgtown, Cannock, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08894670
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Gentili United Kingdom Limited Fairway
- Off Delta Way
- Bridgtown
- Cannock
- WS11 0DJ
- England Gentili United Kingdom Limited Fairway, Off Delta Way, Bridgtown, Cannock, WS11 0DJ, England UK
Management
- Geschäftsführung
- GENTILI, Ernesto
- ROBOTTOM, Ian Paul
- CHAMBERS, Joseph William Paul
- Prokuristen
- CHAMBERS, Lyn Denise
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 14.02.2014
- Alter der Firma 2014-02-14 10 Jahre
- SIC/NACE
- 45310
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Gentili Technology Equipment Srl
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- MPD TRADING LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-09-30
- Letzte Einreichung: 2020-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-02-02
- Letzte Einreichung: 2021-01-19
-
GENTILI UNITED KINGDOM LIMITED Firmenbeschreibung
- GENTILI UNITED KINGDOM LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08894670. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 14.02.2014 registriert. GENTILI UNITED KINGDOM LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen MPD TRADING LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "45310" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer und 1 Prokuristen.Die Firma kann schriftlich über Gentili United Kingdom Limited Fairway erreicht werden.
Jetzt sichern GENTILI UNITED KINGDOM LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Gentili United Kingdom Limited - Gentili United Kingdom Limited Fairway, Off Delta Way, Bridgtown, Cannock, Grossbritannien
- 2014-02-14
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu GENTILI UNITED KINGDOM LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
confirmation-statement-with-updates (2021-02-23) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-12-23) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
capital-allotment-shares (2020-10-09) - SH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-12-23) - AA
-
capital-allotment-shares (2020-12-23) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-09-22) - AP01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-01-20) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-09-22) - TM01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-01-29) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-09-30) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-03-09) - MR01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2018-03-07) - MR04
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-02-22) - PSC05
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-02-01) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-09-28) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-09-29) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-01-31) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-09-29) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-04-01) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-01-22) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-01-19) - AR01
-
capital-allotment-shares (2015-01-19) - SH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-09-29) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
incorporation-company (2014-02-14) - NEWINC
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-12-07) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-12-05) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-12-05) - TM01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2014-12-05) - AP03
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2014-12-05) - AD01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2014-05-12) - AA01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2014-02-27) - MR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-12-11) - AP01
-
certificate-change-of-name-company (2014-12-05) - CERTNM