-
BRANDPATH GROUP LIMITED - Network House Third Avenue, Globe Park, Marlow, Buckinghamshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08877584
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Network House Third Avenue
- Globe Park
- Marlow
- Buckinghamshire
- SL7 1EY Network House Third Avenue, Globe Park, Marlow, Buckinghamshire, SL7 1EY UK
Management
- Geschäftsführung
- JONES, Peter David
- Prokuristen
- HOLDGATE, James Edward Peter
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 05.02.2014
- Alter der Firma 2014-02-05 10 Jahre
- SIC/NACE
- 82990
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- -
- Pj Investment Group Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- PDJ BIDCO LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2025-01-31
- Letzte Einreichung: 2023-04-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2025-02-19
- Letzte Einreichung: 2024-02-05
-
BRANDPATH GROUP LIMITED Firmenbeschreibung
- BRANDPATH GROUP LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08877584. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 05.02.2014 registriert. BRANDPATH GROUP LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen PDJ BIDCO LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "82990" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer und 1 Prokuristen.Die Firma kann schriftlich über Network House Third Avenue erreicht werden.
Jetzt sichern BRANDPATH GROUP LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Brandpath Group Limited - Network House Third Avenue, Globe Park, Marlow, Buckinghamshire, Grossbritannien
- 2014-02-05
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu BRANDPATH GROUP LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
confirmation-statement-with-no-updates (2024-02-05) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-group (2024-01-31) - AA
keyboard_arrow_right 2023
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2023-01-03) - TM01
-
change-person-director-company-with-change-date (2023-10-04) - CH01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2023-04-06) - MR01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-02-06) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-group (2023-01-31) - AA
keyboard_arrow_right 2022
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2022-11-03) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-group (2022-03-11) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2022-10-11) - AP01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-02-07) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-09-06) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-09-01) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-group (2021-04-29) - AA
-
resolution (2021-03-16) - RESOLUTIONS
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-03-01) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-03-01) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2021-02-05) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-updates (2020-02-05) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2020-03-02) - PSC02
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-02-05) - PSC07
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-08-04) - AP01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-03-02) - PSC07
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-01-29) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2020-07-10) - MR04
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2020-04-22) - MR01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-full (2019-01-31) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-02-05) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-12-13) - PSC02
keyboard_arrow_right 2018
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-11-16) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-full (2018-01-29) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-02-09) - CS01
-
change-of-name-notice (2018-11-08) - CONNOT
-
resolution (2018-11-08) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2017
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-01-25) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-full (2017-02-03) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-02-05) - CS01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-05-05) - MR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-09-06) - TM01
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-02-15) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-full (2016-02-04) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-02-05) - AR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-05-26) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-group (2015-02-16) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-12-16) - AP01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2014-10-28) - AA01
-
incorporation-company (2014-02-05) - NEWINC