-
BUSINESS COLLABORATOR LIMITED - Reading Bridge House, George Street, Reading, RG1 8LS, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08850750
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Reading Bridge House
- George Street
- Reading
- RG1 8LS Reading Bridge House, George Street, Reading, RG1 8LS UK
Management
- Geschäftsführung
- HACKFORTH, Clive
- VALOIS, Francois
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 17.01.2014
- Alter der Firma 2014-01-17 10 Jahre
- SIC/NACE
- 62012
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Bentley Systems (Uk) Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active — Active proposal to strike off
- Ehemalige Namen
- ENSCO 1040 LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-08-31
- Letzte Einreichung: 2020-11-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2023-01-31
- Letzte Einreichung: 2022-01-17
-
BUSINESS COLLABORATOR LIMITED Firmenbeschreibung
- BUSINESS COLLABORATOR LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08850750. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 17.01.2014 registriert. BUSINESS COLLABORATOR LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen ENSCO 1040 LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "62012" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30.11.2018 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Reading Bridge House erreicht werden.
Jetzt sichern BUSINESS COLLABORATOR LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Business Collaborator Limited - Reading Bridge House, George Street, Reading, RG1 8LS, Grossbritannien
- 2014-01-17
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu BUSINESS COLLABORATOR LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
dissolution-application-strike-off-company (2023-02-22) - DS01
-
dissolution-voluntary-strike-off-suspended (2023-03-02) - SOAS(A)
-
gazette-notice-voluntary (2023-03-07) - GAZ1(A)
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-03-18) - CS01
-
gazette-notice-compulsory (2022-11-01) - GAZ1
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2022-11-26) - DISS16(SOAS)
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-updates (2021-04-12) - CS01
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2021-08-23) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-09-02) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-small (2020-12-01) - AA
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-03-24) - PSC07
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-03-24) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-01-30) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2020-03-24) - PSC02
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-03-24) - AP01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2020-03-17) - MR04
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-02-13) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-small (2019-03-14) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
memorandum-articles (2018-09-19) - MA
-
resolution (2018-09-19) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-small (2018-06-08) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-02-08) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-01-31) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-01-26) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-full (2017-07-12) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-full (2016-04-18) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-02-29) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
resolution (2015-12-16) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2015-12-08) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2015-11-26) - MR04
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-09-25) - TM01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2015-08-04) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-03-02) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-03-02) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-01-30) - AP01
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-01-16) - CH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-01-07) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-01-05) - AP01
-
capital-allotment-shares (2015-01-29) - SH01
keyboard_arrow_right 2014
-
incorporation-company (2014-01-17) - NEWINC
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-07-07) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-07-28) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-10-22) - AP01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2014-10-27) - TM02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-10-27) - TM01
-
certificate-change-of-name-company (2014-10-30) - CERTNM
-
capital-allotment-shares (2014-12-18) - SH01
-
capital-alter-shares-subdivision (2014-12-18) - SH02
-
capital-name-of-class-of-shares (2014-12-18) - SH08
-
capital-variation-of-rights-attached-to-shares (2014-12-18) - SH10
-
resolution (2014-12-18) - RESOLUTIONS
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2014-11-26) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2014-12-04) - MR01