-
UNA ST IVES HOMES LIMITED - Hyde Park House, 5 Manfred Road, London, SW15 2RS, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08850537
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Hyde Park House
- 5 Manfred Road
- London
- SW15 2RS
- United Kingdom Hyde Park House, 5 Manfred Road, London, SW15 2RS, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- CHAPMAN, Nigel Peter
- NARES, Anthony James Brewis
- TAYLOR, Carole Lesley
- Prokuristen
- DERRINGTONS LIMITED
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 17.01.2014
- Alter der Firma 2014-01-17 10 Jahre
- SIC/NACE
- 68100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Kingfisher Resorts St Ives Limited
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-09-30
- Letzte Einreichung: 2019-12-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-01-31
- Letzte Einreichung: 2021-01-17
-
UNA ST IVES HOMES LIMITED Firmenbeschreibung
- UNA ST IVES HOMES LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08850537. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 17.01.2014 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "68100" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 30.12.2019 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Hyde Park House erreicht werden.
Jetzt sichern UNA ST IVES HOMES LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Una St Ives Homes Limited - Hyde Park House, 5 Manfred Road, London, SW15 2RS, Grossbritannien
- 2014-01-17
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu UNA ST IVES HOMES LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-02-09) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-01-24) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-12-22) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-09-17) - TM01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-12-23) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2019-12-12) - MR04
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2019-09-25) - AA01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-05-10) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-01-23) - CS01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2019-01-02) - MR04
keyboard_arrow_right 2018
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-04-04) - PSC05
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-04-04) - AD01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-02-02) - CS01
-
appoint-corporate-secretary-company-with-name-date (2018-10-16) - AP04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-09-28) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-11-22) - CH01
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-08-10) - CH01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-01) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-01-19) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-12-21) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-10-21) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-11-07) - AP01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-10-25) - MR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-10-21) - AP01
-
termination-director-company (2016-10-21) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2016-10-21) - TM02
-
accounts-with-accounts-type-full (2016-08-23) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2016-10-12) - MR04
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2016-10-13) - TM02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-10-13) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-01-27) - AR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-10-18) - MR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-10-21) - AD01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-full (2015-10-08) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-01-19) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-01-19) - CH01
keyboard_arrow_right 2014
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2014-01-23) - AA01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2014-01-23) - CH03
-
capital-name-of-class-of-shares (2014-03-11) - SH08
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2014-03-25) - MR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-11-13) - TM01
-
memorandum-articles (2014-04-08) - MEM/ARTS
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-11-13) - AP01
-
resolution (2014-04-08) - RESOLUTIONS
-
incorporation-company (2014-01-17) - NEWINC