-
LSI ARCHITECTS (DESIGN) LIMITED - The Old Drill Hall, 23a Cattle Market Street, Norwich, Norfolk, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08842621
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- The Old Drill Hall
- 23a Cattle Market Street
- Norwich
- Norfolk
- NR1 3DY The Old Drill Hall, 23a Cattle Market Street, Norwich, Norfolk, NR1 3DY UK
Management
- Geschäftsführung
- ANDREWS, David Bryan
- ANDREWS, Sally Ann
- COURTNEY, Peter William
- GOODE, Benjamin Kevin James
- KITCHEN, Rupert Henry
- Prokuristen
- GOODE, Benjamin Kevin James
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 13.01.2014
- Alter der Firma 2014-01-13 10 Jahre
- SIC/NACE
- 71111
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Lsi Design Holdings Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2025-01-31
- Letzte Einreichung: 2023-04-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-01-27
- Letzte Einreichung: 2023-01-13
-
LSI ARCHITECTS (DESIGN) LIMITED Firmenbeschreibung
- LSI ARCHITECTS (DESIGN) LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08842621. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 13.01.2014 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "71111" registriert. Das Unternehmen hat 5 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 30.04.2023 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über The Old Drill Hall erreicht werden.
Jetzt sichern LSI ARCHITECTS (DESIGN) LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Lsi Architects (Design) Limited - The Old Drill Hall, 23a Cattle Market Street, Norwich, Norfolk, Grossbritannien
- 2014-01-13
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu LSI ARCHITECTS (DESIGN) LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
second-filing-of-confirmation-statement-with-made-up-date (2023-08-11) - RP04CS01
-
confirmation-statement (2023-01-25) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-08-07) - AA
-
statement-of-companys-objects (2023-08-08) - CC04
-
memorandum-articles (2023-08-11) - MA
-
resolution (2023-08-11) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2022
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-11-03) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2022-02-08) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2022-01-26) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-01-14) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-updates (2021-02-19) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
withdrawal-of-a-person-with-significant-control-statement (2020-02-17) - PSC09
-
confirmation-statement-with-updates (2020-02-07) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2020-02-17) - PSC02
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-11-27) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
resolution (2019-06-11) - RESOLUTIONS
-
capital-name-of-class-of-shares (2019-12-20) - SH08
-
resolution (2019-12-17) - RESOLUTIONS
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-12-12) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-11-11) - AA
-
memorandum-articles (2019-06-11) - MA
-
capital-allotment-shares (2019-05-10) - SH01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-01-21) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-11-09) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-05-29) - MR01
-
resolution (2018-05-23) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2018-04-16) - SH01
-
capital-allotment-shares (2018-04-13) - SH01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-01-17) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-01-11) - CH01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-01-17) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-01-18) - CH01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-01-18) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-11-14) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-11-28) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-07-12) - AP01
keyboard_arrow_right 2016
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-08-04) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-01-14) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-10-20) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-01-19) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-05-14) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-05-12) - AP01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2014-01-13) - AA01
-
incorporation-company (2014-01-13) - NEWINC