-
BOULTBEE BROOKS (HATTON WALL) LIMITED - 2nd Floor Broadway House, 32-35 Broad Street, Hereford, HR4 9AR, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08800498
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 2nd Floor Broadway House
- 32-35 Broad Street
- Hereford
- HR4 9AR 2nd Floor Broadway House, 32-35 Broad Street, Hereford, HR4 9AR UK
Management
- Geschäftsführung
- BOULTBEE BROOKS, Clive Ensor
- MESHIEA, Aziz
- NADER, Kamil Yousef
- ROBERTS, Lee
- Prokuristen
- THOMPSON, Martin Lee
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 03.12.2013
- Gelöscht am:
- 2022-06-14
- SIC/NACE
- 68100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Clive Ensor Boultbee Brooks
- Mr Yousef Meshiea
- Mr Yousef Meshiea
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-09-30
- Letzte Einreichung: 2019-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-12-17
- Letzte Einreichung: 2020-12-03
-
BOULTBEE BROOKS (HATTON WALL) LIMITED Firmenbeschreibung
- BOULTBEE BROOKS (HATTON WALL) LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08800498. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 03.12.2013 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "68100" registriert. Das Unternehmen hat 4 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2019 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 2Nd Floor Broadway House erreicht werden.
Jetzt sichern BOULTBEE BROOKS (HATTON WALL) LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Boultbee Brooks (Hatton Wall) Limited - 2nd Floor Broadway House, 32-35 Broad Street, Hereford, HR4 9AR, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu BOULTBEE BROOKS (HATTON WALL) LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2022
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2022-01-08) - DISS16(SOAS)
keyboard_arrow_right 2021
-
gazette-notice-compulsory (2021-11-30) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-12-16) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-12-16) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-12-12) - CS01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2019-12-11) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-10-01) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-12-14) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-12-13) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-10-01) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-08-09) - AP01
keyboard_arrow_right 2017
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-07-13) - AP01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-12-15) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-10-05) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-07-27) - TM01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2016-10-03) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-12-13) - CS01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2016-05-19) - TM02
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2016-05-19) - AP03
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-01-06) - MR01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-12-08) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2015-09-11) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-07-17) - MR01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-12-12) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2014-07-24) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-07-24) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-07-22) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-07-22) - AP01
keyboard_arrow_right 2013
-
incorporation-company (2013-12-03) - NEWINC