-
SAMUEL BEILIN AND PARTNERS LIMITED - C/O Stuart Mcbain Ltd (Accountants) 18 Tower Street, Brunswick Business Park, Liverpool, Merseyside, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08780175
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- C/O Stuart Mcbain Ltd (Accountants) 18 Tower Street
- Brunswick Business Park
- Liverpool
- Merseyside
- L3 4BJ
- England C/O Stuart Mcbain Ltd (Accountants) 18 Tower Street, Brunswick Business Park, Liverpool, Merseyside, L3 4BJ, England UK
Management
- Geschäftsführung
- JAGOTA, Paul
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 18.11.2013
- Alter der Firma 2013-11-18 10 Jahre
- SIC/NACE
- 70100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Paul Jagota
- Mr Paul Jagota
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2020-11-30
- Letzte Einreichung: 2018-11-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-12-02
- Letzte Einreichung: 2021-11-18
-
SAMUEL BEILIN AND PARTNERS LIMITED Firmenbeschreibung
- SAMUEL BEILIN AND PARTNERS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08780175. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 18.11.2013 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "70100" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30.11.2018 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über C/o Stuart Mcbain Ltd (Accountants) 18 Tower Street erreicht werden.
Jetzt sichern SAMUEL BEILIN AND PARTNERS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Samuel Beilin And Partners Limited - C/O Stuart Mcbain Ltd (Accountants) 18 Tower Street, Brunswick Business Park, Liverpool, Merseyside, Grossbritannien
- 2013-11-18
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu SAMUEL BEILIN AND PARTNERS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-02-11) - AD01
-
gazette-notice-compulsory (2021-01-26) - GAZ1
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2021-12-16) - DISS40
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-12-15) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-12-15) - AP01
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2021-08-05) - DISS16(SOAS)
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2021-02-06) - DISS16(SOAS)
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-06-01) - TM01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2021-03-05) - DISS40
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-03-04) - CS01
-
gazette-notice-compulsory (2021-07-27) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2020-01-03) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2019-12-24) - DISS40
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-12-23) - CS01
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2019-11-09) - DISS16(SOAS)
-
gazette-notice-compulsory (2019-11-05) - GAZ1
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-04-16) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-03-22) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-05-03) - CS01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2018-05-05) - DISS40
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-05-15) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2018-12-01) - DISS40
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2018-11-13) - DISS16(SOAS)
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-12-12) - AP01
-
gazette-notice-compulsory (2018-11-06) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2017
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2017-11-11) - DISS16(SOAS)
-
gazette-notice-compulsory (2017-10-31) - GAZ1
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-01-08) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-12-28) - CS01
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2016-11-15) - DISS16(SOAS)
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2016-12-31) - DISS40
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2016-02-09) - AA
-
gazette-notice-compulsory (2016-11-01) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-12-23) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-12-23) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-12-23) - AD01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-12-23) - TM01
-
gazette-notice-compulsory (2015-11-17) - GAZ1
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2015-12-26) - DISS40
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-03-03) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-06-20) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2014-06-20) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-04-30) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2014-04-30) - TM01
keyboard_arrow_right 2013
-
termination-secretary-company-with-name (2013-11-25) - TM02
-
termination-director-company-with-name (2013-11-25) - TM01
-
incorporation-company (2013-11-18) - NEWINC