-
AMS BIDCO LTD - 1 More London Place, London, SE1 2AF, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08745260
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 1 More London Place
- London
- SE1 2AF 1 More London Place, London, SE1 2AF UK
Management
- Geschäftsführung
- BLAIR, Rosaleen
- RODGER, Matthew Charles
- WHITTAKER, Elizabeth Anne
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 23.10.2013
- Gelöscht am:
- 2021-09-21
- SIC/NACE
- 64209
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Ams Midco Limited
Landes-Besonderheiten
- Firmenname (in Englisch)
- AMS Bidco LTD
- Zusätzliche Statusdetails
- Dissolved
- Ehemalige Namen
- VIOLIN NEWCO LTD
- Rechtsträger-Kennung (LEI)
- 213800W9SJBCVLGTD487
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2020-03-31
- Letzte Einreichung: 2017-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2020-12-04
- Letzte Einreichung: 2019-10-23
-
AMS BIDCO LTD Firmenbeschreibung
- AMS BIDCO LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08745260. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 23.10.2013 registriert. AMS BIDCO LTD hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen VIOLIN NEWCO LTD ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "64209" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über 1 More London Place erreicht werden.
Jetzt sichern AMS BIDCO LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Ams Bidco Ltd - 1 More London Place, London, SE1 2AF, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu AMS BIDCO LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
gazette-dissolved-liquidation (2021-09-21) - GAZ2
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2021-02-03) - LIQ03
-
liquidation-voluntary-members-return-of-final-meeting (2021-06-21) - LIQ13
keyboard_arrow_right 2020
-
move-registers-to-sail-company-with-new-address (2020-01-13) - AD03
-
change-sail-address-company-with-new-address (2020-01-13) - AD02
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-01-08) - AD01
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2020-01-08) - 600
-
resolution (2020-01-08) - RESOLUTIONS
-
liquidation-voluntary-declaration-of-solvency (2020-01-08) - LIQ01
keyboard_arrow_right 2019
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-06-05) - TM01
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2019-09-20) - AA01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-10-23) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-06-08) - AP01
-
capital-allotment-shares (2019-11-07) - SH01
-
resolution (2019-11-07) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-11-01) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-full (2018-06-29) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2018-06-27) - MR04
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-11-03) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-full (2017-09-07) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2017-06-02) - MR04
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-06-01) - MR01
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-11-03) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-full (2016-06-22) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-11-13) - AR01
-
capital-statement-capital-company-with-date-currency-figure (2015-06-30) - SH19
-
legacy (2015-06-30) - SH20
-
legacy (2015-06-30) - CAP-SS
-
resolution (2015-06-30) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-full (2015-06-19) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-02-21) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2014-01-04) - TM01
-
resolution (2014-01-09) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2014-01-09) - SH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2014-01-22) - AD01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2014-01-22) - AA01
-
termination-secretary-company-with-name (2014-01-22) - TM02
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-02-27) - CH01
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-01-04) - AP01
-
legacy (2014-06-17) - GUARANTEE2
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2014-08-18) - AD01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2014-09-01) - AD01
-
legacy (2014-10-07) - AGREEMENT2
-
legacy (2014-10-07) - PARENT_ACC
-
accounts-with-accounts-type-audit-exemption-subsiduary (2014-10-07) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-11-20) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2013-12-31) - MR01
-
incorporation-company (2013-10-23) - NEWINC
-
certificate-change-of-name-company (2013-12-23) - CERTNM