-
FLUID GRAVITY LIMITED - DR MARTIN HAYNES, The Old Coach House, 1 West Street, Emsworth, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08729273
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- DR MARTIN HAYNES
- The Old Coach House
- 1 West Street
- Emsworth
- Hampshire
- PO10 7DX DR MARTIN HAYNES, The Old Coach House, 1 West Street, Emsworth, Hampshire, PO10 7DX UK
Management
- Geschäftsführung
- EVANS, David John
- HAYNES, Martin, Doctor
- JOHNSTONE, Emma Marie
- LONGBOTTOM, Aaron William, Dr
- MERRIFIELD, James Anthony, Dr
- PARKER, Andrew John, Dr
- Prokuristen
- JOHNSTONE, Emma Marie
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 11.10.2013
- Alter der Firma 2013-10-11 10 Jahre
- SIC/NACE
- 72190
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- APPLIED COMPUTATIONAL PHYSICS LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-04-30
- Letzte Einreichung: 2020-07-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-10-25
- Letzte Einreichung: 2020-10-11
-
FLUID GRAVITY LIMITED Firmenbeschreibung
- FLUID GRAVITY LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08729273. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 11.10.2013 registriert. FLUID GRAVITY LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen APPLIED COMPUTATIONAL PHYSICS LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "72190" registriert. Das Unternehmen hat 6 Geschäftsführer und 1 Prokuristen.Die Firma kann schriftlich über Dr Martin Haynes erreicht werden.
Jetzt sichern FLUID GRAVITY LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Fluid Gravity Limited - DR MARTIN HAYNES, The Old Coach House, 1 West Street, Emsworth, Grossbritannien
- 2013-10-11
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu FLUID GRAVITY LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-04-20) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-07-28) - TM01
-
capital-cancellation-shares (2021-08-03) - SH06
-
resolution (2021-08-09) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-updates (2020-10-20) - CS01
-
capital-cancellation-shares (2020-09-07) - SH06
-
resolution (2020-09-07) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-03-27) - AA
-
capital-return-purchase-own-shares (2020-09-07) - SH03
keyboard_arrow_right 2019
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-10-17) - CH01
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-10-15) - CH01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2019-05-29) - TM02
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2019-05-28) - AP03
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-04-23) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-02-22) - CH01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-10-17) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-10-11) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-07-19) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-04-03) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-03-20) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2017-11-27) - MR04
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-10-11) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-10-15) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-03-11) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-10-12) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-04-14) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-10-23) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-10-23) - CH01
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-06-09) - CH01
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-07-04) - CH01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2014-01-26) - AA01
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-01-26) - CH01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2014-01-27) - CH03
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-02-09) - CH01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2014-02-10) - CH03
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-02-10) - CH01
keyboard_arrow_right 2013
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-12-04) - AD01
-
certificate-change-of-name-company (2013-12-02) - CERTNM
-
change-of-name-notice (2013-12-02) - CONNOT
-
capital-allotment-shares (2013-11-21) - SH01
-
resolution (2013-11-21) - RESOLUTIONS
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2013-11-19) - MR01
-
incorporation-company (2013-10-11) - NEWINC
-
mortgage-alter-charge-with-charge-number (2013-12-11) - MR07