-
CLEANSLATE (WESTON) LTD - 4 Kennet House, 19 High Street, Hungerford, Berkshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08722734
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 4 Kennet House
- 19 High Street
- Hungerford
- Berkshire
- RG17 0NL
- England 4 Kennet House, 19 High Street, Hungerford, Berkshire, RG17 0NL, England UK
Management
- Geschäftsführung
- FITZPATRICK, Mark Coleman
- NORTON, Brian Richard
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 08.10.2013
- Alter der Firma 2013-10-08 10 Jahre
- SIC/NACE
- 74990
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Cleanslate Group Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Ehemalige Namen
- CLEANSLATE (READING) LTD
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-12-31
- Letzte Einreichung: 2023-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2025-01-17
- Letzte Einreichung: 2024-01-03
-
CLEANSLATE (WESTON) LTD Firmenbeschreibung
- CLEANSLATE (WESTON) LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08722734. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 08.10.2013 registriert. CLEANSLATE (WESTON) LTD hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen CLEANSLATE (READING) LTD ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "74990" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über 4 Kennet House erreicht werden.
Jetzt sichern CLEANSLATE (WESTON) LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Cleanslate (Weston) Ltd - 4 Kennet House, 19 High Street, Hungerford, Berkshire, Grossbritannien
- 2013-10-08
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu CLEANSLATE (WESTON) LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2024-01-03) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2024-01-03) - PSC02
-
confirmation-statement-with-updates (2024-01-03) - CS01
keyboard_arrow_right 2023
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2023-11-09) - AD01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-10-10) - CS01
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2023-05-10) - AA01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2023-05-08) - TM02
-
mortgage-satisfy-charge-full (2023-02-21) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-12-19) - AA
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-updates (2022-10-18) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-09-30) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-10-25) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-09-29) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-12-23) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-10-21) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-10-18) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-10-04) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-08-28) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-10-18) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-03-01) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-10-18) - CS01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2017-10-18) - AP03
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2017-10-18) - TM02
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-09-12) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-01-23) - TM01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2017-01-23) - MR04
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-10-11) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-small (2016-10-04) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-05-03) - CH01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-10-13) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-03-26) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2014-11-12) - AA01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2014-10-16) - MR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-10-07) - AR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2014-08-08) - MR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-07-22) - AP01
-
certificate-change-of-name-company (2014-03-25) - CERTNM
keyboard_arrow_right 2013
-
incorporation-company (2013-10-08) - NEWINC