-
BIOTECH ENERGY (ESCO 33) LIMITED - 4th, Floor, 36 Spital Square, London, E1 6DY, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08717811
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 4th
- Floor, 36 Spital Square
- London
- E1 6DY
- England 4th, Floor, 36 Spital Square, London, E1 6DY, England UK
Management
- Geschäftsführung
- BULLEN, Dean Peter
- Prokuristen
- MAY, Graham Philip
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 03.10.2013
- Gelöscht am:
- 2021-04-06
- SIC/NACE
- 35110
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Craig Reeves
- Biotech Energy Operations Limited
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Ehemalige Namen
- H2 ENERGY (ESCO 33) LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2020-12-28
- Letzte Einreichung: 2018-12-28
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-10-17
- Letzte Einreichung: 2020-10-03
-
BIOTECH ENERGY (ESCO 33) LIMITED Firmenbeschreibung
- BIOTECH ENERGY (ESCO 33) LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08717811. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 03.10.2013 registriert. BIOTECH ENERGY (ESCO 33) LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen H2 ENERGY (ESCO 33) LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "35110" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 28.12.2018 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 4Th erreicht werden.
Jetzt sichern BIOTECH ENERGY (ESCO 33) LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Biotech Energy (Esco 33) Limited - 4th, Floor, 36 Spital Square, London, E1 6DY, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu BIOTECH ENERGY (ESCO 33) LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
dissolution-application-strike-off-company (2021-01-12) - DS01
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-02-24) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2020-12-24) - MR04
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-10-05) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2019-12-19) - AA01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-10-08) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-10-08) - PSC02
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-10-08) - PSC07
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2019-09-25) - AA01
keyboard_arrow_right 2018
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-09-14) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-small (2018-06-14) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-10-17) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-10-17) - AD01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-10-19) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-small (2017-07-06) - AA
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2017-06-14) - AP03
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2017-06-14) - TM02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-01-19) - TM01
-
capital-allotment-shares (2017-01-19) - SH01
-
accounts-with-accounts-type-small (2017-01-06) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
auditors-resignation-company (2016-11-16) - AUD
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2016-09-26) - AA01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-06-14) - AD01
-
resolution (2016-06-02) - RESOLUTIONS
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-04-29) - TM01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-03-21) - MR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-02-11) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2016-10-04) - CS01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-10-22) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-small (2015-10-14) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
termination-secretary-company-with-name (2014-06-11) - TM02
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-06-11) - AP01
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2014-06-11) - AP03
-
capital-allotment-shares (2014-06-11) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-10-08) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2014-09-03) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-10-14) - AR01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2014-08-13) - AA01
keyboard_arrow_right 2013
-
incorporation-company (2013-10-03) - NEWINC