-
NEW SPARTA FILMS LIMITED - Willowdene, Barneshall Avenue, Worcester, WR5 3EU, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08699848
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Willowdene
- Barneshall Avenue
- Worcester
- WR5 3EU
- England Willowdene, Barneshall Avenue, Worcester, WR5 3EU, England UK
Management
- Geschäftsführung
- BOOTH, Jerome Paul, Dr
- SIMON, Christopher Charles
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 20.09.2013
- Alter der Firma 2013-09-20 10 Jahre
- SIC/NACE
- 59131
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Jerome Paul Booth
- Mrs Nicola Karen Hattingh
- Dr Jerome Paul Booth
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-09-30
- Letzte Einreichung: 2022-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2023-10-04
- Letzte Einreichung: 2022-09-20
-
NEW SPARTA FILMS LIMITED Firmenbeschreibung
- NEW SPARTA FILMS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08699848. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 20.09.2013 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "59131" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2022 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Willowdene erreicht werden.
Jetzt sichern NEW SPARTA FILMS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: New Sparta Films Limited - Willowdene, Barneshall Avenue, Worcester, WR5 3EU, Grossbritannien
- 2013-09-20
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu NEW SPARTA FILMS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-09-28) - AA
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-09-25) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-09-30) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-10-10) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-09-11) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-09-30) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-10-02) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-11-06) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-10-04) - PSC04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-09-30) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-04-03) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-10-04) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-09-28) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-10-19) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-10-19) - PSC04
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-10-19) - CH01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-10-09) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-09-29) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-08-22) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-07-19) - TM01
keyboard_arrow_right 2016
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-12-05) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-10-31) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2016-10-31) - TM02
-
mortgage-satisfy-charge-full (2016-08-04) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-09-30) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-03-10) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2016-10-04) - CS01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-11-05) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-06-18) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-04-20) - MR01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-09-25) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
capital-allotment-shares (2013-12-03) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-11-14) - AP01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2013-11-14) - AA01
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2013-11-14) - AP03
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-10-16) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2013-09-24) - TM01
-
incorporation-company (2013-09-20) - NEWINC