-
NORMCYBER LIMITED - 8 Barnes Wallis Road, Fareham, PO15 5TU, England, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08683680
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 8 Barnes Wallis Road
- Fareham
- PO15 5TU
- England 8 Barnes Wallis Road, Fareham, PO15 5TU, England UK
Management
- Geschäftsführung
- BOWERS, Peter John
- CHURCHILL, Wayne Winston
- CRAGG, Paul Anthony
- PEREZ, David
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 10.09.2013
- Alter der Firma 2013-09-10 10 Jahre
- SIC/NACE
- 62020
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Mr Wayne Churchill
- -
- Mr Wayne Churchill
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- THINK MARBLE LTD
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2020-06-30
- Letzte Einreichung: 2018-09-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-07-06
- Letzte Einreichung: 2020-06-22
-
NORMCYBER LIMITED Firmenbeschreibung
- NORMCYBER LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08683680. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 10.09.2013 registriert. NORMCYBER LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen THINK MARBLE LTD ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "62020" registriert. Das Unternehmen hat 4 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30.09.2018 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 8 Barnes Wallis Road erreicht werden.
Jetzt sichern NORMCYBER LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Normcyber Limited - 8 Barnes Wallis Road, Fareham, PO15 5TU, England, Grossbritannien
- 2013-09-10
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu NORMCYBER LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
confirmation-statement-with-updates (2020-06-22) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-01-07) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-01-07) - AP01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2020-05-13) - PSC04
-
resolution (2020-01-27) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2020-02-06) - SH01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-05-13) - PSC07
-
capital-allotment-shares (2020-01-07) - SH01
keyboard_arrow_right 2019
-
second-filing-capital-allotment-shares (2019-04-05) - RP04SH01
-
capital-allotment-shares (2019-04-08) - SH01
-
resolution (2019-04-09) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-06-18) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2019-10-23) - CS01
-
resolution (2019-12-04) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2018
-
capital-allotment-shares (2018-12-17) - SH01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-10-22) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-10-10) - CH01
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-10-09) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-06-29) - AA
-
resolution (2018-12-31) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-10-12) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-08-03) - CH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-08-01) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-06-29) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-10-21) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-11-07) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-01-08) - AP01
-
resolution (2016-01-22) - RESOLUTIONS
-
capital-name-of-class-of-shares (2016-01-22) - SH08
-
capital-alter-shares-subdivision (2016-01-22) - SH02
-
capital-allotment-shares (2016-01-26) - SH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-07-04) - AA
-
capital-variation-of-rights-attached-to-shares (2016-01-22) - SH10
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-07-22) - AP01
-
capital-allotment-shares (2016-07-22) - SH01
-
capital-allotment-shares (2016-07-26) - SH01
-
capital-variation-of-rights-attached-to-shares (2016-08-26) - SH10
-
resolution (2016-08-31) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2015
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-04-14) - CH01
-
gazette-notice-compulsory (2015-01-13) - GAZ1
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2015-03-31) - DISS40
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-04-07) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-04-14) - AR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-10-08) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-06-14) - AD01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-10-08) - AD01
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-10-08) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2015-06-14) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
incorporation-company (2013-09-10) - NEWINC