-
NIMBUS MEDICAL LIMITED - Stanhope House Mark Rake, Bromborough, Wirral, Merseyside, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08672040
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Stanhope House Mark Rake
- Bromborough
- Wirral
- Merseyside
- CH62 2DN Stanhope House Mark Rake, Bromborough, Wirral, Merseyside, CH62 2DN UK
Management
- Geschäftsführung
- CURTIS, John Sydney
- KOLKMAN, Arjan
- NWF4B DIRECTORS LIMITED
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 02.09.2013
- Gelöscht am:
- 2020-02-04
- SIC/NACE
- 82990
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- -
- Nimbus Medical Holdings Ltd
- -
- -
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit:
- Letzte Einreichung: 2017-12-31
-
NIMBUS MEDICAL LIMITED Firmenbeschreibung
- NIMBUS MEDICAL LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08672040. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 02.09.2013 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "82990" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30.09.2014 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Stanhope House Mark Rake erreicht werden.
Jetzt sichern NIMBUS MEDICAL LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Nimbus Medical Limited - Stanhope House Mark Rake, Bromborough, Wirral, Merseyside, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu NIMBUS MEDICAL LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
gazette-dissolved-compulsory (2020-02-04) - GAZ2
keyboard_arrow_right 2019
-
mortgage-satisfy-charge-full (2019-08-22) - MR04
-
gazette-notice-compulsory (2019-11-19) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-09-28) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-09-13) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-11-07) - TM01
-
accounts-amended-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-11-02) - AAMD
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-09-29) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-09-15) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-09-15) - PSC02
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2017-09-15) - PSC07
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-01-04) - MR01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-09-29) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-09-13) - CS01
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2016-04-08) - AA01
-
capital-allotment-shares (2016-08-02) - SH01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-11-02) - AR01
-
appoint-corporate-director-company-with-name-date (2015-10-28) - AP02
-
capital-allotment-shares (2015-10-09) - SH01
-
resolution (2015-10-09) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2015-05-29) - AA
-
capital-alter-shares-subdivision (2015-04-13) - SH02
-
resolution (2015-04-13) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2015-02-23) - SH01
-
resolution (2015-01-23) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2014
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-12-15) - AP01
-
capital-allotment-shares (2014-10-13) - SH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-10-10) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
incorporation-company (2013-09-02) - NEWINC