-
CLEARWATER (HAILSHAM) LIMITED - Unit 2., 02 High Weald House, Glovers End, Bexhill, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08651068
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Unit 2.
- 02 High Weald House
- Glovers End
- Bexhill
- East Sussex
- TN39 5ES
- England Unit 2., 02 High Weald House, Glovers End, Bexhill, East Sussex, TN39 5ES, England UK
Management
- Geschäftsführung
- NEILLY, Steven James Graham
- WESTERN, Keith Joseph
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 14.08.2013
- Gelöscht am:
- 2022-02-15
- SIC/NACE
- 41100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Keith Joseph Western
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Ehemalige Namen
- OAK FIELD (HAILSHAM) LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-05-26
- Letzte Einreichung: 2019-02-28
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-08-14
- Letzte Einreichung: 2021-07-31
-
CLEARWATER (HAILSHAM) LIMITED Firmenbeschreibung
- CLEARWATER (HAILSHAM) LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08651068. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 14.08.2013 registriert. CLEARWATER (HAILSHAM) LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen OAK FIELD (HAILSHAM) LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "41100" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über Unit 2. erreicht werden.
Jetzt sichern CLEARWATER (HAILSHAM) LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Clearwater (Hailsham) Limited - Unit 2., 02 High Weald House, Glovers End, Bexhill, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu CLEARWATER (HAILSHAM) LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2021-08-13) - DISS40
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2021-02-26) - AA01
-
gazette-notice-compulsory (2021-07-27) - GAZ1
-
confirmation-statement-with-updates (2021-08-12) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2021-08-13) - PSC04
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-updates (2020-08-06) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2020-03-18) - CH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-03-18) - AD01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-08-20) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-12-06) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-11-27) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2019-05-29) - AA01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-08-14) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-05-31) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-09-22) - CH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-06-23) - AD01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2017-09-22) - PSC04
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-09-25) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-05-31) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-10-14) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-03-09) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-10-12) - CH01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-08-08) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-08-05) - MR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-05-26) - AP01
-
resolution (2016-04-22) - RESOLUTIONS
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-04-05) - AD01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-03-03) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-03-03) - AP01
keyboard_arrow_right 2015
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2015-09-19) - DISS16(SOAS)
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-12-11) - AR01
-
gazette-notice-compulsory (2015-08-11) - GAZ1
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2015-12-12) - DISS40
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-09-24) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
incorporation-company (2013-08-14) - NEWINC