-
BOOMBOD LTD - Haslers, Old Station Road, Loughton, Essex, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08631207
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Haslers
- Old Station Road
- Loughton
- Essex
- IG10 4PL
- United Kingdom Haslers, Old Station Road, Loughton, Essex, IG10 4PL, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- ROSS, Jack Raymond
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 30.07.2013
- Alter der Firma 2013-07-30 10 Jahre
- SIC/NACE
- 47789
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Jack Raymond Ross
- -
- -
- -
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Ehemalige Namen
- WE R BRAND LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-09-30
- Letzte Einreichung: 2022-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-10-25
- Letzte Einreichung: 2023-10-11
-
BOOMBOD LTD Firmenbeschreibung
- BOOMBOD LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08631207. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 30.07.2013 registriert. BOOMBOD LTD hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen WE R BRAND LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "47789" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über Haslers erreicht werden.
Jetzt sichern BOOMBOD LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Boombod Ltd - Haslers, Old Station Road, Loughton, Essex, Grossbritannien
- 2013-07-30
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu BOOMBOD LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2024-03-19) - AA
-
gazette-notice-compulsory (2024-01-02) - GAZ1
-
confirmation-statement-with-updates (2024-01-04) - CS01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2024-01-06) - DISS40
keyboard_arrow_right 2023
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-01-17) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2023-09-25) - AA01
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-updates (2022-11-18) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2021-01-27) - DISS40
-
gazette-notice-compulsory (2021-01-26) - GAZ1
-
confirmation-statement-with-updates (2021-01-20) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-09-30) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2021-11-16) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-10-26) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-02-19) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2020-01-24) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-01-08) - TM01
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2019-04-09) - AA01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-01-08) - PSC01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-01-08) - PSC07
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-01-08) - AP01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-04-30) - AA
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-08-29) - PSC04
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-09-11) - AP01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-09-12) - PSC07
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-08-29) - CH01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-11-15) - CS01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-12-18) - MR01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-03-13) - PSC01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-09-12) - PSC01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-03-13) - PSC07
keyboard_arrow_right 2017
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-10-10) - PSC01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2017-10-10) - PSC07
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-09-01) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-05-05) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-03-15) - TM01
-
capital-allotment-shares (2017-02-13) - SH01
-
resolution (2017-02-09) - RESOLUTIONS
-
capital-alter-shares-subdivision (2017-02-08) - SH02
-
confirmation-statement-with-updates (2017-10-18) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-09-01) - CS01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-29) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-05-07) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-08-12) - AD01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2016-08-12) - TM02
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-08-12) - AP01
-
certificate-change-of-name-company (2016-02-16) - CERTNM
-
confirmation-statement-with-updates (2016-10-13) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-12-19) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-08-12) - TM01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-08-14) - AR01
-
capital-allotment-shares (2015-11-10) - SH01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-11-03) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-07-31) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
incorporation-company (2013-07-30) - NEWINC