-
HAINES WATTS SERVICE CHARGE LIMITED - 1 Rushmills, Northampton, NN4 7YB, England, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08627405
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 1 Rushmills
- Northampton
- NN4 7YB
- England 1 Rushmills, Northampton, NN4 7YB, England UK
Management
- Geschäftsführung
- MINIFIE, Andrew Stephen
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 29.07.2013
- Gelöscht am:
- 2020-10-13
- SIC/NACE
- 99999
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Fortus Midlands Limited
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Ehemalige Namen
- HAINES WATTS LUTON LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-03-31
- Letzte Einreichung: 2019-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-06-14
- Letzte Einreichung: 2020-05-31
-
HAINES WATTS SERVICE CHARGE LIMITED Firmenbeschreibung
- HAINES WATTS SERVICE CHARGE LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08627405. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 29.07.2013 registriert. HAINES WATTS SERVICE CHARGE LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen HAINES WATTS LUTON LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "99999" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über 1 Rushmills erreicht werden.
Jetzt sichern HAINES WATTS SERVICE CHARGE LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Haines Watts Service Charge Limited - 1 Rushmills, Northampton, NN4 7YB, England, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu HAINES WATTS SERVICE CHARGE LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
gazette-notice-voluntary (2020-07-14) - GAZ1(A)
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-05-12) - TM01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2020-05-14) - PSC05
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2020-05-14) - CH03
-
change-person-director-company-with-change-date (2020-05-14) - CH01
-
dissolution-application-strike-off-company (2020-07-06) - DS01
-
confirmation-statement-with-updates (2020-06-01) - CS01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2020-06-30) - TM02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-06-30) - TM01
keyboard_arrow_right 2019
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2019-05-29) - CH03
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-05-30) - CH01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-05-31) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-10-10) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-12-19) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-updates (2018-05-31) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-05-31) - PSC02
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-05-31) - PSC07
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-12-05) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-11-26) - AA
-
capital-allotment-shares (2017-08-17) - SH01
-
capital-statement-capital-company-with-date-currency-figure (2017-08-15) - SH19
-
legacy (2017-08-15) - SH20
-
legacy (2017-08-15) - CAP-SS
-
resolution (2017-08-15) - RESOLUTIONS
-
confirmation-statement-with-updates (2017-08-10) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-08-01) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-04-13) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-04-13) - TM01
-
resolution (2017-04-03) - RESOLUTIONS
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-03-03) - AD01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-08-15) - PSC01
keyboard_arrow_right 2016
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-05-13) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-05-13) - AP01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2016-05-13) - CH03
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-05-13) - CH01
-
capital-allotment-shares (2016-06-27) - SH01
-
resolution (2016-06-27) - RESOLUTIONS
-
confirmation-statement-with-updates (2016-09-21) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-12-09) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-12-23) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-07-17) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-11-18) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-07-25) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-04-02) - AP01
keyboard_arrow_right 2013
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-11-12) - AD01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2013-11-04) - AA01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2013-10-28) - MR01
-
incorporation-company (2013-07-29) - NEWINC