-
HYDROFIT ALLIANCE LTD - Redheugh House, Teesdale South, Thornaby Place, Stock On Tees, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08610961
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Redheugh House
- Teesdale South
- Thornaby Place
- Stock On Tees
- TS17 6SA Redheugh House, Teesdale South, Thornaby Place, Stock On Tees, TS17 6SA UK
Management
- Geschäftsführung
- HINCHCLIFFE, Lee John
- KAY, Anthony Charles
- VAKKAYIL, Mohammed Rasheed
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 16.07.2013
- Gelöscht am:
- 2020-02-18
- SIC/NACE
- 25990
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2016-09-30
- Letzte Einreichung: 2014-12-31
-
HYDROFIT ALLIANCE LTD Firmenbeschreibung
- HYDROFIT ALLIANCE LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08610961. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 16.07.2013 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "25990" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über Redheugh House erreicht werden.
Jetzt sichern HYDROFIT ALLIANCE LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Hydrofit Alliance Ltd - Redheugh House, Teesdale South, Thornaby Place, Stock On Tees, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu HYDROFIT ALLIANCE LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
gazette-dissolved-liquidation (2020-02-18) - GAZ2
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-voluntary-creditors-return-of-final-meeting (2019-11-18) - LIQ14
keyboard_arrow_right 2018
-
liquidation-voluntary-removal-of-liquidator-by-court (2018-07-30) - LIQ10
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2018-07-20) - LIQ03
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2018-07-12) - 600
keyboard_arrow_right 2017
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2017-07-20) - LIQ03
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-02-13) - AD01
keyboard_arrow_right 2016
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2016-06-21) - 600
-
liquidation-in-administration-progress-report-with-brought-down-date (2016-06-14) - 2.24B
-
liquidation-in-administration-move-to-creditors-voluntary-liquidation (2016-05-24) - 2.34B
-
liquidation-in-administration-statement-of-affairs-with-form-attached (2016-05-20) - 2.16B
-
liquidation-in-administration-result-creditors-meeting (2016-04-25) - 2.23B
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-04-08) - AD01
-
liquidation-in-administration-proposals (2016-04-08) - 2.17B
-
liquidation-in-administration-appointment-of-administrator (2016-04-07) - 2.12B
keyboard_arrow_right 2015
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-11-10) - TM01
-
accounts-amended-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-11-06) - AAMD
-
mortgage-satisfy-charge-full (2015-10-30) - MR04
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-09-01) - MR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-07-17) - AR01
-
accounts-amended-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-04-26) - AAMD
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-03-12) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-09-25) - AR01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2014-04-07) - AA01
keyboard_arrow_right 2013
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-11-27) - AP01
-
capital-allotment-shares (2013-11-27) - SH01
-
incorporation-company (2013-07-16) - NEWINC