-
SKETCH AGENCY LIMITED - 85 Great Portland Street, London, W1W 7LT, England, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08603513
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 85 Great Portland Street
- London
- W1W 7LT
- England 85 Great Portland Street, London, W1W 7LT, England UK
Management
- Geschäftsführung
- WOTTON, Luke Robert
- WYLIE, James Thomas
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 10.07.2013
- Alter der Firma 2013-07-10 11 Jahre
- SIC/NACE
- 73110
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr James Thomas Wylie
- Mr Luke Robert Wotton
- -
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active — Active proposal to strike off
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-04-30
- Letzte Einreichung: 2022-07-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2023-07-24
- Letzte Einreichung: 2022-07-10
-
SKETCH AGENCY LIMITED Firmenbeschreibung
- SKETCH AGENCY LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08603513. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 10.07.2013 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "73110" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.07.2022 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 85 Great Portland Street erreicht werden.
Jetzt sichern SKETCH AGENCY LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Sketch Agency Limited - 85 Great Portland Street, London, W1W 7LT, England, Grossbritannien
- 2013-07-10
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu SKETCH AGENCY LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
gazette-notice-compulsory (2023-10-03) - GAZ1
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2023-11-14) - DISS16(SOAS)
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2023-07-27) - AA
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-09-14) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2022-04-27) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2021-08-06) - PSC07
-
change-to-a-person-with-significant-control (2021-08-02) - PSC04
-
change-to-a-person-with-significant-control (2021-07-30) - PSC04
-
confirmation-statement-with-updates (2021-07-30) - CS01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2021-07-30) - DISS40
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2021-07-29) - AA
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2021-07-22) - DISS16(SOAS)
-
gazette-notice-compulsory (2021-07-06) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2020
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-10-07) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2020-07-31) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-07-30) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2020-10-12) - PSC04
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-09-13) - CS01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2019-07-27) - DISS40
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2019-07-24) - AA
-
gazette-notice-compulsory (2019-07-02) - GAZ1
-
mortgage-satisfy-charge-full (2019-02-14) - MR04
keyboard_arrow_right 2018
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-05-24) - PSC07
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-05-24) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2018-04-26) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-09-10) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-08-02) - AD01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-04-30) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-07-16) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-07-10) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-04-05) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-04-06) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-05-24) - AD01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-09-01) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-11-08) - MR01
keyboard_arrow_right 2015
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-06-04) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-07-29) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-11-17) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2014-05-16) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-05-21) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-07-22) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-11-04) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-10-31) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-09-23) - TM01
-
termination-director-company-with-name (2014-07-03) - TM01
keyboard_arrow_right 2013
-
incorporation-company (2013-07-10) - NEWINC