-
AVERY HOMES TH LIMITED - 3 Cygnet Drive, Swan Valley, Northampton, NN4 9BS, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08595643
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 3 Cygnet Drive
- Swan Valley
- Northampton
- NN4 9BS 3 Cygnet Drive, Swan Valley, Northampton, NN4 9BS UK
Management
- Geschäftsführung
- PROCTOR, Matthew Frederick
- STROWBRIDGE, John Michael Barrie
- COLT, Carl Leopold Cronstedt
- OLSSON, Sebastian Bratanis
- Prokuristen
- PROCTOR, Matthew Frederick
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 03.07.2013
- Alter der Firma 2013-07-03 10 Jahre
- SIC/NACE
- 87300
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Willowbrook Healthcare Debtco Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2023-12-31
- Letzte Einreichung: 2022-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2023-07-17
- Letzte Einreichung: 2022-07-03
-
AVERY HOMES TH LIMITED Firmenbeschreibung
- AVERY HOMES TH LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08595643. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 03.07.2013 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "87300" registriert. Das Unternehmen hat 4 Geschäftsführer und 1 Prokuristen.Die Firma kann schriftlich über 3 Cygnet Drive erreicht werden.
Jetzt sichern AVERY HOMES TH LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Avery Homes Th Limited - 3 Cygnet Drive, Swan Valley, Northampton, NN4 9BS, Grossbritannien
- 2013-07-03
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu AVERY HOMES TH LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
accounts-with-accounts-type-full (2023-03-31) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2023-03-13) - AP01
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-07-03) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-audit-exemption-subsiduary (2022-06-17) - AA
-
legacy (2022-06-17) - PARENT_ACC
-
legacy (2022-06-17) - AGREEMENT2
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2022-03-15) - TM01
-
legacy (2022-06-17) - GUARANTEE2
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-audit-exemption-subsiduary (2021-04-28) - AA
-
legacy (2021-04-28) - PARENT_ACC
-
legacy (2021-04-28) - AGREEMENT2
-
legacy (2021-04-28) - GUARANTEE2
-
legacy (2021-04-16) - AGREEMENT2
-
legacy (2021-04-16) - GUARANTEE2
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-07-04) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
legacy (2020-02-05) - GUARANTEE2
-
legacy (2020-02-05) - PARENT_ACC
-
legacy (2020-02-05) - AGREEMENT2
-
accounts-with-accounts-type-audit-exemption-subsiduary (2020-02-05) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-07-03) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-07-04) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-07-04) - PSC05
keyboard_arrow_right 2018
-
legacy (2018-01-04) - AGREEMENT2
-
accounts-with-accounts-type-audit-exemption-subsiduary (2018-09-14) - AA
-
legacy (2018-09-14) - GUARANTEE2
-
legacy (2018-09-07) - PARENT_ACC
-
legacy (2018-09-07) - AGREEMENT2
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-07-03) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-audit-exemption-subsiduary (2018-01-04) - AA
-
legacy (2018-01-04) - PARENT_ACC
-
legacy (2018-01-04) - GUARANTEE2
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-07-03) - CS01
-
legacy (2017-01-25) - GUARANTEE2
-
legacy (2017-01-25) - AGREEMENT2
-
legacy (2017-02-03) - PARENT_ACC
-
accounts-with-accounts-type-audit-exemption-subsiduary (2017-02-03) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
legacy (2016-01-21) - PARENT_ACC
-
accounts-with-accounts-type-audit-exemption-subsiduary (2016-01-21) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-07-07) - CS01
-
legacy (2016-01-19) - GUARANTEE2
-
legacy (2016-01-19) - AGREEMENT2
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-audit-exemption-subsiduary (2015-01-16) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-07-09) - AR01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2015-07-06) - MR04
keyboard_arrow_right 2014
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2014-11-12) - MR01
-
legacy (2014-10-28) - PARENT_ACC
-
legacy (2014-10-28) - AGREEMENT2
-
legacy (2014-10-28) - GUARANTEE2
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2014-08-28) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-07-22) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2013-08-20) - AA01
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2013-12-16) - AP03
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2013-07-26) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2013-07-19) - MR01
-
incorporation-company (2013-07-03) - NEWINC
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-09-16) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2013-09-16) - TM01