-
DAVID CUFFE LIMITED - The Innovation Centre Airedale Business Centre, Millennium Road, Skipton, North Yorkshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08588839
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- The Innovation Centre Airedale Business Centre
- Millennium Road
- Skipton
- North Yorkshire
- BD23 2TZ
- United Kingdom The Innovation Centre Airedale Business Centre, Millennium Road, Skipton, North Yorkshire, BD23 2TZ, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- CUFFE, Carol Ann
- CUFFE, David John Claude
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 28.06.2013
- Alter der Firma 2013-06-28 10 Jahre
- SIC/NACE
- 75000
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr David John Claude Cuffe
- -
- -
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- LONDON ANIMAL HOSPITAL LTD.
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2020-09-30
- Letzte Einreichung: 2018-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2020-08-09
- Letzte Einreichung: 2019-07-26
-
DAVID CUFFE LIMITED Firmenbeschreibung
- DAVID CUFFE LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08588839. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 28.06.2013 registriert. DAVID CUFFE LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen LONDON ANIMAL HOSPITAL LTD. ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "75000" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2018 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über The Innovation Centre Airedale Business Centre erreicht werden.
Jetzt sichern DAVID CUFFE LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: David Cuffe Limited - The Innovation Centre Airedale Business Centre, Millennium Road, Skipton, North Yorkshire, Grossbritannien
- 2013-06-28
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu DAVID CUFFE LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-01-31) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-01-31) - AP01
keyboard_arrow_right 2019
-
mortgage-satisfy-charge-full (2019-10-08) - MR04
-
accounts-amended-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-12-10) - AAMD
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-07-26) - PSC07
-
confirmation-statement-with-updates (2019-07-26) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-07-29) - PSC04
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-05-23) - AD01
-
resolution (2019-09-04) - RESOLUTIONS
-
change-of-name-notice (2019-09-04) - CONNOT
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-06-05) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-01-17) - PSC01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-09-25) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-07-02) - CS01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-06-13) - PSC07
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-06-13) - TM01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-02-19) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2018-02-19) - TM02
keyboard_arrow_right 2017
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-11-19) - AD01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-06-30) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-06-30) - PSC01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2017-06-26) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-05-03) - AD01
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2017-03-24) - AA01
keyboard_arrow_right 2016
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2016-02-08) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-02-10) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2016-05-09) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-08-06) - AR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-10-19) - MR01
keyboard_arrow_right 2015
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-10-17) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-07-17) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2015-02-16) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-07-01) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
incorporation-company (2013-06-28) - NEWINC