-
DAVIS PAYROLL LIMITED - Hampdon House Falcon Court, Preston Farm Industrial Estate, Stockton-On-Tees, TS18 3TS, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08586896
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Hampdon House Falcon Court
- Preston Farm Industrial Estate
- Stockton-On-Tees
- TS18 3TS
- England Hampdon House Falcon Court, Preston Farm Industrial Estate, Stockton-On-Tees, TS18 3TS, England UK
Management
- Geschäftsführung
- BONNARD, Sarah Louise
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 27.06.2013
- Alter der Firma 2013-06-27 10 Jahre
- SIC/NACE
- 69202
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Miss Sarah Louise Bonnard
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- OPTICARE ANTRIM LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-09-30
- Letzte Einreichung: 2020-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2023-01-06
- Letzte Einreichung: 2021-12-23
-
DAVIS PAYROLL LIMITED Firmenbeschreibung
- DAVIS PAYROLL LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08586896. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 27.06.2013 registriert. DAVIS PAYROLL LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen OPTICARE ANTRIM LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "69202" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2020 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Hampdon House Falcon Court erreicht werden.
Jetzt sichern DAVIS PAYROLL LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Davis Payroll Limited - Hampdon House Falcon Court, Preston Farm Industrial Estate, Stockton-On-Tees, TS18 3TS, Grossbritannien
- 2013-06-27
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu DAVIS PAYROLL LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2022
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-01-05) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-03-10) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-updates (2020-12-23) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-01-15) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2020-01-15) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-03-11) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-09-05) - AD01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-11-01) - CS01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-11-01) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-11-01) - PSC01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2019-09-17) - AA01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-07-11) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-10-18) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-09-24) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-03-07) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-12-14) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-09-11) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-11-11) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-11-02) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-03-29) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-05-13) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-07-24) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-07-24) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-04-30) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-04-30) - AP01
-
capital-allotment-shares (2015-04-09) - SH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-03-30) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2015-02-25) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-10-08) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-10-07) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-11-05) - AR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-10-07) - TM01
-
certificate-change-of-name-company (2014-10-14) - CERTNM
keyboard_arrow_right 2013
-
incorporation-company (2013-06-27) - NEWINC