-
JFS HOME FARM BIOGAS LTD - Marlborough House Westminster Place, Nether Poppleton, York, YO26 6RW, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08584152
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Marlborough House Westminster Place
- Nether Poppleton
- York
- YO26 6RW
- England Marlborough House Westminster Place, Nether Poppleton, York, YO26 6RW, England UK
Management
- Geschäftsführung
- MACKENZIE, Graham Andrew
- MILLS, Peter
- RICHARDSON, Peter Michael
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 25.06.2013
- Alter der Firma 2013-06-25 10 Jahre
- SIC/NACE
- 35110
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Iona Capital Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2020-12-31
- Letzte Einreichung: 2019-09-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2020-08-06
- Letzte Einreichung: 2019-06-25
-
JFS HOME FARM BIOGAS LTD Firmenbeschreibung
- JFS HOME FARM BIOGAS LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08584152. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 25.06.2013 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "35110" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30.09.2019 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Marlborough House Westminster Place erreicht werden.
Jetzt sichern JFS HOME FARM BIOGAS LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Jfs Home Farm Biogas Ltd - Marlborough House Westminster Place, Nether Poppleton, York, YO26 6RW, Grossbritannien
- 2013-06-25
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu JFS HOME FARM BIOGAS LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
accounts-with-accounts-type-small (2020-07-01) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2020-06-19) - MR04
-
mortgage-satisfy-charge-full (2020-06-12) - MR04
keyboard_arrow_right 2019
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2019-11-01) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-small (2019-07-04) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-06-27) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-03-13) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-07-02) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-07-02) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-06-29) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-06-11) - MR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-03-13) - AP01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-07-27) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-07-03) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-07-03) - PSC02
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-03-02) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-01-30) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-01-03) - TM01
keyboard_arrow_right 2016
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-12-12) - TM01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-12-09) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-small (2016-07-05) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-06-29) - AR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-05-06) - MR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-04-22) - TM01
keyboard_arrow_right 2015
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-08-17) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-08-17) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-07-23) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-small (2015-04-09) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
resolution (2014-01-16) - RESOLUTIONS
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-01-16) - AP01
-
capital-allotment-shares (2014-02-26) - SH01
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-03-14) - CH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2014-07-22) - AD01
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-09-08) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-09-08) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-11-05) - CH01
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2014-11-27) - AA01
keyboard_arrow_right 2013
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2013-12-06) - MR01
-
incorporation-company (2013-06-25) - NEWINC