-
STEPJOCKEY LTD - 2nd Floor Stratus House, Emperor Way, Exeter, Devon, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08579579
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 2nd Floor Stratus House
- Emperor Way
- Exeter
- Devon
- EX1 3QS 2nd Floor Stratus House, Emperor Way, Exeter, Devon, EX1 3QS UK
Management
- Geschäftsführung
- ASHURKOV, Vladimir
- MOORE, Duncan Charles Mcnaught
- MUTHU, Vivek Sundar
- VILLE, Matthew
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 21.06.2013
- Alter der Firma 2013-06-21 10 Jahre
- SIC/NACE
- 74909
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Ms Helen Jane Nuki
- Mr. Paul Nuki
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Liquidation
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2020-03-31
- Letzte Einreichung: 2018-06-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2020-08-30
- Letzte Einreichung: 2019-07-19
-
STEPJOCKEY LTD Firmenbeschreibung
- STEPJOCKEY LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08579579. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 21.06.2013 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "74909" registriert. Das Unternehmen hat 4 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30.06.2018 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 2Nd Floor Stratus House erreicht werden.
Jetzt sichern STEPJOCKEY LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Stepjockey Ltd - 2nd Floor Stratus House, Emperor Way, Exeter, Devon, Grossbritannien
- 2013-06-21
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu STEPJOCKEY LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
liquidation-voluntary-creditors-return-of-final-meeting (2023-12-10) - LIQ14
keyboard_arrow_right 2022
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2022-12-09) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2021
-
liquidation-voluntary-removal-of-liquidator-by-court (2021-04-20) - LIQ10
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2021-04-20) - 600
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2021-12-01) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2020
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2020-12-14) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2019
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-04-10) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-04-30) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-06-26) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-06-18) - AD01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-08-14) - AD01
-
resolution (2019-10-17) - RESOLUTIONS
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2019-10-17) - 600
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2019-10-17) - LIQ02
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-10-18) - AD01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-07-31) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-06-19) - AP01
keyboard_arrow_right 2018
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-09-30) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-08-01) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2018-04-03) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
capital-allotment-shares (2017-06-08) - SH01
-
capital-allotment-shares (2017-12-19) - SH01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-09-01) - CS01
-
second-filing-capital-allotment-shares (2017-07-25) - RP04SH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-03-20) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-07-19) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-02-29) - AA
-
capital-alter-shares-subdivision (2016-12-04) - SH02
keyboard_arrow_right 2015
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-03-05) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-03-17) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-03-23) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-07-10) - AR01
-
capital-allotment-shares (2015-08-06) - SH01
-
resolution (2015-08-12) - RESOLUTIONS
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-09-10) - AP01
-
capital-allotment-shares (2015-08-04) - SH01
keyboard_arrow_right 2014
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-05-08) - AP01
-
capital-allotment-shares (2014-05-01) - SH01
-
resolution (2014-05-08) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2014-11-25) - SH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-07-08) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2014-10-28) - AD01
-
resolution (2014-11-20) - RESOLUTIONS
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-05-15) - AP01
keyboard_arrow_right 2013
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-06-21) - AD01
-
incorporation-company (2013-06-21) - NEWINC