-
DE POEL CLARITY LIMITED - Booths Park 1, Chelford Road, Knutsford, Cheshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08578570
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Booths Park 1
- Chelford Road
- Knutsford
- Cheshire
- WA16 8GS
- England Booths Park 1, Chelford Road, Knutsford, Cheshire, WA16 8GS, England UK
Management
- Geschäftsführung
- COLES, Catherine
- SMITH, Samantha Jane
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 20.06.2013
- Alter der Firma 2013-06-20 10 Jahre
- SIC/NACE
- 78200
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Brookfield Rose Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2023-09-30
- Letzte Einreichung: 2021-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-06-28
- Letzte Einreichung: 2023-06-14
-
DE POEL CLARITY LIMITED Firmenbeschreibung
- DE POEL CLARITY LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08578570. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 20.06.2013 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "78200" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2021 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Booths Park 1 erreicht werden.
Jetzt sichern DE POEL CLARITY LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: De Poel Clarity Limited - Booths Park 1, Chelford Road, Knutsford, Cheshire, Grossbritannien
- 2013-06-20
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu DE POEL CLARITY LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2023-09-22) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2023-09-22) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-06-14) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2023-06-14) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2023-06-14) - TM01
keyboard_arrow_right 2022
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2022-01-06) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2022-06-01) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2022-01-06) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2022-10-04) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2022-09-01) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-07-08) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2022-11-17) - TM01
keyboard_arrow_right 2021
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-12-31) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2021-09-27) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-08-09) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2020-11-30) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-09-01) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-06-27) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2019-09-30) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-07-11) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-06-19) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2018-04-20) - MR04
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-09-19) - PSC02
keyboard_arrow_right 2017
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-04-05) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-09-05) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-07-24) - CS01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2017-03-03) - TM02
keyboard_arrow_right 2016
-
resolution (2016-10-20) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2016-10-04) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-09-26) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-09-22) - MR01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2016-09-21) - AP03
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-07-06) - AR01
-
memorandum-articles (2016-10-20) - MA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-09-21) - TM01
keyboard_arrow_right 2015
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-11-17) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-small (2015-10-13) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-07-03) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-small (2014-10-07) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-08-08) - AR01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2014-06-06) - AA01
keyboard_arrow_right 2013
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2013-11-09) - MR01
-
incorporation-company (2013-06-20) - NEWINC