-
LAVATECH LIMITED - C/O Simpson Burgess Nash Empress Business Centre, 380 Chester Road, Manchester, M16 9EA, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08561166
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- C/O Simpson Burgess Nash Empress Business Centre
- 380 Chester Road
- Manchester
- M16 9EA
- England C/O Simpson Burgess Nash Empress Business Centre, 380 Chester Road, Manchester, M16 9EA, England UK
Management
- Geschäftsführung
- AMIN, Hilpa Sucheet
- AMIN, Sucheet Rashmikant
- ARGYLE, James Alexander
- HOSIER, Robert John
- KIRKHAM, Andrew
- MCLOUGHLIN, Maurice
- MORROW, David
- SCAIFE, Andrew John
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 07.06.2013
- Alter der Firma 2013-06-07 10 Jahre
- SIC/NACE
- 62012
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mrs Hilpa Sucheet Amin
- Mr Sucheet Rashmikant Amin
- Project Ophelia Bidco Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-03-31
- Letzte Einreichung: 2019-06-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-06-21
- Letzte Einreichung: 2020-06-07
-
LAVATECH LIMITED Firmenbeschreibung
- LAVATECH LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08561166. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 07.06.2013 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "62012" registriert. Das Unternehmen hat 8 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30.06.2019 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über C/o Simpson Burgess Nash Empress Business Centre erreicht werden.
Jetzt sichern LAVATECH LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Lavatech Limited - C/O Simpson Burgess Nash Empress Business Centre, 380 Chester Road, Manchester, M16 9EA, Grossbritannien
- 2013-06-07
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu LAVATECH LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
change-person-director-company-with-change-date (2020-06-09) - CH01
-
resolution (2020-05-20) - RESOLUTIONS
-
memorandum-articles (2020-05-20) - MA
-
capital-name-of-class-of-shares (2020-05-20) - SH08
-
change-to-a-person-with-significant-control (2020-05-18) - PSC05
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2020-05-18) - PSC02
-
capital-allotment-shares (2020-05-18) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-05-18) - AP01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2020-01-30) - MR04
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-05-13) - AP01
-
change-person-director-company-with-change-date (2020-05-13) - CH01
-
confirmation-statement-with-updates (2020-06-18) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-06-12) - CH01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-06-12) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-11-15) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-09-26) - CH01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-09-26) - PSC04
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-10-23) - AA
-
capital-alter-shares-subdivision (2018-09-21) - SH02
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-06-08) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-01-23) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-04-12) - MR01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-01-16) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-05-26) - AD01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-06-13) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-06-20) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-06-20) - CH01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-10-13) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-03-05) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-07-03) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2014-09-19) - MR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-06-26) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
incorporation-company (2013-06-07) - NEWINC