-
NEXON SCM GROUP LIMITED - Charwood House, Oakhurst Business Park, Southwater, West Sussex, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08560885
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Charwood House
- Oakhurst Business Park
- Southwater
- West Sussex
- RH13 9RT
- United Kingdom Charwood House, Oakhurst Business Park, Southwater, West Sussex, RH13 9RT, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- ANDREWS, Jonathan Mark
- CAMPBELL, Charles Allan
- CRITCHLEY, Robert Andrew
- GREEN, Donald Michael
- GREEN, Ralph Timothy
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 07.06.2013
- Alter der Firma 2013-06-07 11 Jahre
- SIC/NACE
- 20412
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- GREEN OF LINCOLN LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-09-30
- Letzte Einreichung: 2022-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-06-18
- Letzte Einreichung: 2023-06-04
-
NEXON SCM GROUP LIMITED Firmenbeschreibung
- NEXON SCM GROUP LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08560885. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 07.06.2013 registriert. NEXON SCM GROUP LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen GREEN OF LINCOLN LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "20412" registriert. Das Unternehmen hat 5 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über Charwood House erreicht werden.
Jetzt sichern NEXON SCM GROUP LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Nexon Scm Group Limited - Charwood House, Oakhurst Business Park, Southwater, West Sussex, Grossbritannien
- 2013-06-07
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu NEXON SCM GROUP LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2023-08-23) - AD01
-
confirmation-statement-with-updates (2023-06-06) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-07-05) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2023-07-06) - MR04
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2023-08-23) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2023-08-23) - AP01
keyboard_arrow_right 2022
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-09-30) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2022-06-08) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-updates (2021-06-09) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-09-15) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-12-07) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2020-06-08) - CS01
-
capital-allotment-shares (2020-05-14) - SH01
-
memorandum-articles (2020-05-11) - MA
-
resolution (2020-01-09) - RESOLUTIONS
-
capital-name-of-class-of-shares (2020-01-09) - SH08
-
resolution (2020-05-11) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-08-14) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2019-06-18) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-09-27) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-06-12) - CH01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-06-12) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-08-07) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-06-16) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-09-19) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-01-06) - MR01
-
resolution (2016-01-29) - RESOLUTIONS
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-02-04) - AP01
-
capital-allotment-shares (2016-02-15) - SH01
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-02-16) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2016-03-31) - AA
-
capital-name-of-class-of-shares (2016-02-15) - SH08
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-05-20) - AD01
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-05-24) - CH01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2016-06-07) - AA01
-
capital-alter-shares-consolidation (2016-08-12) - SH02
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-08-15) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-05-05) - AD01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2015-03-09) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-07-08) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
resolution (2014-10-09) - RESOLUTIONS
-
change-of-name-notice (2014-10-02) - CONNOT
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-07-22) - AR01
-
certificate-change-of-name-company (2014-10-16) - CERTNM
keyboard_arrow_right 2013
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-06-07) - AD01
-
incorporation-company (2013-06-07) - NEWINC