-
PEAK GEN TOP CO LIMITED - Gables Lodge, 62, Kenilworth Road, Leamington Spa, Warwickshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08544585
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Gables Lodge
- 62, Kenilworth Road
- Leamington Spa
- Warwickshire
- CV32 6JX Gables Lodge, 62, Kenilworth Road, Leamington Spa, Warwickshire, CV32 6JX UK
Management
- Geschäftsführung
- ALVAREZ LANDALUCE, Jose-Ignacio
- ALVAREZ LANDALUCE, Jose-Miguel
- DRAPER, Mark Robert
- GRAVES, Ian Robert
- Prokuristen
- HARBEN, Jessica Anne Lisa
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 24.05.2013
- Alter der Firma 2013-05-24 11 Jahre
- SIC/NACE
- 70100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Janek Paul Matthews
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Rechtsträger-Kennung (LEI)
- 2138002L9HTJ4TTVBY49
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-06-30
- Letzte Einreichung: 2020-09-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-09-02
- Letzte Einreichung: 2021-08-19
-
PEAK GEN TOP CO LIMITED Firmenbeschreibung
- PEAK GEN TOP CO LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08544585. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 24.05.2013 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "70100" registriert. Das Unternehmen hat 4 Geschäftsführer und 1 Prokuristen.Die Firma kann schriftlich über Gables Lodge erreicht werden.
Jetzt sichern PEAK GEN TOP CO LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Peak Gen Top Co Limited - Gables Lodge, 62, Kenilworth Road, Leamington Spa, Warwickshire, Grossbritannien
- 2013-05-24
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu PEAK GEN TOP CO LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-09-01) - CS01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2021-01-13) - TM02
-
accounts-with-accounts-type-group (2021-06-28) - AA
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2021-01-13) - AP03
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-08-19) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-group (2020-08-05) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-09-02) - CS01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2019-06-28) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-group (2019-06-27) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-04-12) - AP01
keyboard_arrow_right 2018
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-01-30) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-01-30) - PSC01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-08-20) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-group (2018-05-04) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-08-31) - CS01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-08-01) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-small (2017-04-07) - AA
-
capital-allotment-shares (2017-03-09) - SH01
-
resolution (2017-01-12) - RESOLUTIONS
-
capital-variation-of-rights-attached-to-shares (2017-01-04) - SH10
keyboard_arrow_right 2016
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-12-22) - MR01
-
confirmation-statement-with-updates (2016-09-05) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-08-30) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-small (2016-05-05) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-09-02) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-small (2015-04-01) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-09-09) - AR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2014-06-24) - MR01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2014-05-29) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-small (2014-05-15) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2013-06-07) - AA01
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-06-19) - AP01
-
memorandum-articles (2013-08-02) - MEM/ARTS
-
resolution (2013-06-28) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2013-06-28) - SH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-08-20) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2013-06-19) - CH01
-
incorporation-company (2013-05-24) - NEWINC