-
ARTURIUS INTERNATIONAL LIMITED - C/O Cvr Global Llp, 20 Furnival Street, London, EC4A 1JQ, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08544422
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- C/O Cvr Global Llp
- 20 Furnival Street
- London
- EC4A 1JQ C/O Cvr Global Llp, 20 Furnival Street, London, EC4A 1JQ UK
Management
- Geschäftsführung
- BALL, Stuart Martyn
- PRESTON, Alex
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 24.05.2013
- Gelöscht am:
- 2021-07-14
- SIC/NACE
- 74909
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Stuart Ball
- Mr Cameron Macnish
- -
- Mr Stuart Ball
- 5dc Holding Ag Ltd
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2020-03-20
- Letzte Einreichung: 2018-01-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2020-05-24
- Letzte Einreichung: 2019-05-10
-
ARTURIUS INTERNATIONAL LIMITED Firmenbeschreibung
- ARTURIUS INTERNATIONAL LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08544422. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 24.05.2013 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "74909" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.05.2014 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über C/o Cvr Global Llp erreicht werden.
Jetzt sichern ARTURIUS INTERNATIONAL LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Arturius International Limited - C/O Cvr Global Llp, 20 Furnival Street, London, EC4A 1JQ, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu ARTURIUS INTERNATIONAL LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-03-12) - AD01
-
resolution (2020-03-11) - RESOLUTIONS
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2020-03-11) - LIQ02
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2020-03-11) - 600
keyboard_arrow_right 2019
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2019-12-20) - AA01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-12-04) - CS01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-05-02) - PSC07
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-01-25) - TM01
keyboard_arrow_right 2018
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-01-24) - TM01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2018-02-16) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-03-23) - AA
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-05-14) - PSC01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-02-16) - AD01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-05-14) - PSC02
-
confirmation-statement-with-updates (2018-05-30) - CS01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2018-11-09) - AA01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2018-03-15) - AA01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-11-30) - AA
-
capital-allotment-shares (2017-10-12) - SH01
-
resolution (2017-10-11) - RESOLUTIONS
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-10-06) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-06-02) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-01-09) - TM01
keyboard_arrow_right 2016
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-06-24) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-12-22) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-06-29) - AR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-06-22) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-06-07) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-05-27) - AP01
-
capital-allotment-shares (2016-02-10) - SH01
-
resolution (2016-02-10) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2015
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-03-06) - AP01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2015-03-24) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-06-25) - AR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-07-08) - TM01
-
capital-allotment-shares (2015-07-29) - SH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-12-21) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2014-03-06) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-03-10) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2014-04-14) - TM01
-
resolution (2014-06-17) - RESOLUTIONS
-
capital-name-of-class-of-shares (2014-06-17) - SH08
-
resolution (2014-09-18) - RESOLUTIONS
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-07-10) - AR01
-
termination-director-company-with-name (2014-07-11) - TM01
-
capital-alter-shares-subdivision (2014-08-11) - SH02
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-08-15) - AA
-
capital-allotment-shares (2014-09-18) - SH01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2014-07-01) - MR01
keyboard_arrow_right 2013
-
incorporation-company (2013-05-24) - NEWINC