-
H ONLINE REALISATIONS LIMITED - 15 Canada Square, Canary Wharf, London, E14 5GL, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08510351
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 15 Canada Square
- Canary Wharf
- London
- E14 5GL 15 Canada Square, Canary Wharf, London, E14 5GL UK
Management
- Geschäftsführung
- FOSTER, Henry William
- MCGOWAN, Paul Patrick
- TAYLOR, Neil Alan
- WOOD, Sally
- Prokuristen
- LOCKHART-ROSS, Inca
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 30.04.2013
- Gelöscht am:
- 2021-03-22
- SIC/NACE
- 47910
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Huk 39 Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Ehemalige Namen
- HMV ONLINE LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2019-09-30
- Letzte Einreichung: 2017-12-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2019-05-14
- Letzte Einreichung: 2018-04-30
-
H ONLINE REALISATIONS LIMITED Firmenbeschreibung
- H ONLINE REALISATIONS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08510351. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 30.04.2013 registriert. H ONLINE REALISATIONS LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen HMV ONLINE LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "47910" registriert. Das Unternehmen hat 4 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 30.12.2017 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 15 Canada Square erreicht werden.
Jetzt sichern H ONLINE REALISATIONS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: H Online Realisations Limited - 15 Canada Square, Canary Wharf, London, E14 5GL, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu H ONLINE REALISATIONS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
liquidation-in-administration-progress-report (2020-08-25) - AM10
-
liquidation-in-administration-progress-report (2020-02-19) - AM10
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-in-administration-statement-of-affairs-with-form-attached (2019-03-13) - AM02
-
liquidation-in-administration-appointment-of-administrator (2019-02-07) - AM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-02-08) - AD01
-
liquidation-in-administration-proposals (2019-03-26) - AM03
-
change-of-name-notice (2019-04-13) - CONNOT
-
resolution (2019-04-13) - RESOLUTIONS
-
liquidation-administration-notice-deemed-approval-of-proposals (2019-04-16) - AM06
-
liquidation-in-administration-extension-of-period (2019-12-10) - AM19
-
mortgage-charge-whole-release-with-charge-number (2019-05-02) - MR05
-
mortgage-charge-part-release-with-charge-number (2019-05-16) - MR05
-
liquidation-in-administration-progress-report (2019-08-27) - AM10
-
mortgage-satisfy-charge-full (2019-05-02) - MR04
keyboard_arrow_right 2018
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-10-01) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-small (2018-09-20) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-07-13) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-07-12) - AP01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-06-01) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-small (2017-10-03) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-10-19) - AD01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-05-30) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-full (2016-09-09) - AA
-
resolution (2016-07-13) - RESOLUTIONS
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-07-06) - MR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-05-23) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-full (2015-10-09) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-05-26) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-05-22) - AP01
keyboard_arrow_right 2014
-
certificate-change-of-name-company (2014-03-11) - CERTNM
-
resolution (2014-04-03) - RESOLUTIONS
-
capital-alter-shares-subdivision (2014-04-03) - SH02
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-04-22) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-04-22) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-05-23) - AR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2014-06-04) - MR01
-
accounts-with-accounts-type- (2014-10-08) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2013-10-18) - AA01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-10-18) - AD01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2013-10-18) - TM01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2013-10-18) - AP03
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2013-10-18) - AP01
-
incorporation-company (2013-04-30) - NEWINC