-
L&P ECOLEAD LIMITED - Faulkner House, Victoria Street, St. Albans, Hertfordshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08480353
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Faulkner House
- Victoria Street
- St. Albans
- Hertfordshire
- AL1 3SE Faulkner House, Victoria Street, St. Albans, Hertfordshire, AL1 3SE UK
Management
- Geschäftsführung
- RINTOUL, David Alistair James
- CRABBE, Ian
- BROAD, Robert James
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 09.04.2013
- Alter der Firma 2013-04-09 11 Jahre
- SIC/NACE
- 74990
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Envirolead Recycling Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-09-30
- Letzte Einreichung: 2022-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-04-23
- Letzte Einreichung: 2023-04-09
-
L&P ECOLEAD LIMITED Firmenbeschreibung
- L&P ECOLEAD LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08480353. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 09.04.2013 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "74990" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2022 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Faulkner House erreicht werden.
Jetzt sichern L&P ECOLEAD LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: L&p Ecolead Limited - Faulkner House, Victoria Street, St. Albans, Hertfordshire, Grossbritannien
- 2013-04-09
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu L&P ECOLEAD LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2024-04-24) - AP01
keyboard_arrow_right 2023
-
confirmation-statement-with-updates (2023-04-24) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-full (2023-08-09) - AA
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-updates (2022-04-21) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-full (2022-08-17) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-full (2021-09-20) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-04-16) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-07-15) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-07-13) - TM01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-04-16) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2021-07-13) - TM02
-
confirmation-statement-with-updates (2021-04-22) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-full (2020-10-13) - AA
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2020-07-28) - TM02
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2020-07-28) - AP03
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-07-28) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2020-05-29) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-full (2020-02-10) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-04-03) - PSC05
-
confirmation-statement-with-updates (2019-05-08) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-small (2018-09-04) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-04-16) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-05-04) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-05-08) - MR01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-05-10) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-full (2017-09-28) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-05-04) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-05-05) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-full (2016-10-02) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-full (2015-09-29) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-06-01) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2015-03-18) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2014-12-17) - AA01
-
resolution (2014-10-10) - RESOLUTIONS
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2014-10-03) - MR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-05-16) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
incorporation-company (2013-04-09) - NEWINC