-
ONEBITE LIMITED - Georgian House Lower Ground Floor, 67 - 71 London Road, Newbury, RG14 1JN, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08460946
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Georgian House Lower Ground Floor
- 67 - 71 London Road
- Newbury
- RG14 1JN
- England Georgian House Lower Ground Floor, 67 - 71 London Road, Newbury, RG14 1JN, England UK
Management
- Geschäftsführung
- WOOD, Thomas Ryan
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 25.03.2013
- Alter der Firma 2013-03-25 11 Jahre
- SIC/NACE
- 70210
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Mr Tom Ryan Wood
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- WHJ VENTURES LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-03-31
- Letzte Einreichung: 2020-06-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2017-03-25
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-04-08
- Letzte Einreichung: 2020-03-25
-
ONEBITE LIMITED Firmenbeschreibung
- ONEBITE LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08460946. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 25.03.2013 registriert. ONEBITE LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen WHJ VENTURES LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "70210" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30.06.2020 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 25.03.2017.Die Firma kann schriftlich über Georgian House Lower Ground Floor erreicht werden.
Jetzt sichern ONEBITE LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Onebite Limited - Georgian House Lower Ground Floor, 67 - 71 London Road, Newbury, RG14 1JN, Grossbritannien
- 2013-03-25
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu ONEBITE LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-01-27) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-04-30) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-04-26) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-04-23) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-02-26) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-11-28) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-06-13) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-05-03) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-03-23) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-02-19) - TM01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-03-29) - AA
-
capital-allotment-shares (2017-12-19) - SH01
-
mortgage-charge-whole-cease-and-release-with-charge-number (2017-12-19) - MR05
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2017-11-13) - PSC07
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-11-13) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-06-19) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-05-03) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
resolution (2016-11-10) - RESOLUTIONS
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-05-09) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
certificate-change-of-name-company (2015-12-04) - CERTNM
-
capital-variation-of-rights-attached-to-shares (2015-02-02) - SH10
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-02-25) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-05-14) - AD01
-
capital-name-of-class-of-shares (2015-02-02) - SH08
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-08-26) - MR01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2015-09-02) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-11-06) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-05-14) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-10-24) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-04-04) - AR01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2014-04-03) - AA01
keyboard_arrow_right 2013
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2013-09-03) - MR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-08-13) - AD01
-
capital-allotment-shares (2013-05-15) - SH01
-
incorporation-company (2013-03-25) - NEWINC