-
HEYSHAM MOSS WIND FARM LIMITED - 6th Floor 338 Euston Road, London, NW1 3BG, England, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08460595
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 6th Floor 338 Euston Road
- London
- NW1 3BG
- England 6th Floor 338 Euston Road, London, NW1 3BG, England UK
Management
- Geschäftsführung
- DANIELS, Stephen Richards
- MOLE, Edward William
- SKELDON, Roger
- TEGERDINE, Elliot
- Prokuristen
- MOLE, Edward William
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 25.03.2013
- Alter der Firma 2013-03-25 11 Jahre
- SIC/NACE
- 35110
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Elm Trading Limited
- Elm Trading Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- BROOK WIND TWO (HEYSHAM MOSS) LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-06-30
- Letzte Einreichung: 2022-09-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-04-08
- Letzte Einreichung: 2023-03-25
-
HEYSHAM MOSS WIND FARM LIMITED Firmenbeschreibung
- HEYSHAM MOSS WIND FARM LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08460595. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 25.03.2013 registriert. HEYSHAM MOSS WIND FARM LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen BROOK WIND TWO (HEYSHAM MOSS) LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "35110" registriert. Das Unternehmen hat 4 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 30.09.2022 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 6Th Floor 338 Euston Road erreicht werden.
Jetzt sichern HEYSHAM MOSS WIND FARM LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Heysham Moss Wind Farm Limited - 6th Floor 338 Euston Road, London, NW1 3BG, England, Grossbritannien
- 2013-03-25
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu HEYSHAM MOSS WIND FARM LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-03-31) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-small (2023-06-23) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2023-07-31) - AP01
-
change-person-director-company-with-change-date (2023-08-03) - CH01
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-04-06) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-small (2022-07-19) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-updates (2021-04-07) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-small (2021-07-10) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-small (2020-09-10) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-03-27) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-05-13) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-small (2019-06-18) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
capital-allotment-shares (2018-11-20) - SH01
-
resolution (2018-09-17) - RESOLUTIONS
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2018-06-20) - AA01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-05-23) - CS01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2018-02-17) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-01-09) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-08-16) - AD01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-04-08) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-08-07) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-08-07) - AP01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2017-08-07) - AP03
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2017-08-16) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-09-26) - PSC02
keyboard_arrow_right 2016
-
resolution (2016-07-19) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-full (2016-08-01) - AA
-
resolution (2016-07-11) - RESOLUTIONS
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-07-19) - MR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-07-11) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-07-11) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-07-11) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2016-07-11) - TM02
-
mortgage-satisfy-charge-full (2016-07-11) - MR04
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-04-11) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-small (2015-01-07) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-03-31) - AR01
-
move-registers-to-registered-office-company-with-new-address (2015-03-31) - AD04
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-11-11) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-small (2015-11-10) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-03-27) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
incorporation-company (2013-03-25) - NEWINC
-
move-registers-to-sail-company (2013-08-05) - AD03
-
change-sail-address-company (2013-08-05) - AD02
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-05-15) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-05-13) - AP01
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2013-05-10) - AP03
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-05-10) - AP01
-
certificate-change-of-name-company (2013-05-07) - CERTNM
-
termination-director-company-with-name (2013-04-03) - TM01