-
GREENERGY BIOFUELS TEESSIDE LIMITED - 198, High Holborn, London, WC1V 7BD, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08460063
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 198
- High Holborn
- London
- WC1V 7BD 198, High Holborn, London, WC1V 7BD UK
Management
- Geschäftsführung
- BATESON, Paul Trevor
- CURTIS, Paul
- TRAEGER, Adam John
- Prokuristen
- CLIFTON, Richard William
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 25.03.2013
- Alter der Firma 2013-03-25 11 Jahre
- SIC/NACE
- 46719
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Greenergy International Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- HARVEST BIOFUELS LIMITED
- Rechtsträger-Kennung (LEI)
- 8945003V1GI1EXFWCV78
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2020-09-30
- Letzte Einreichung: 2018-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-04-08
- Letzte Einreichung: 2020-03-25
-
GREENERGY BIOFUELS TEESSIDE LIMITED Firmenbeschreibung
- GREENERGY BIOFUELS TEESSIDE LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08460063. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 25.03.2013 registriert. GREENERGY BIOFUELS TEESSIDE LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen HARVEST BIOFUELS LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "46719" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2018 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 198 erreicht werden.
Jetzt sichern GREENERGY BIOFUELS TEESSIDE LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Greenergy Biofuels Teesside Limited - 198, High Holborn, London, WC1V 7BD, Grossbritannien
- 2013-03-25
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu GREENERGY BIOFUELS TEESSIDE LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-03-25) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-03-24) - TM01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-03-26) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-full (2019-09-27) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-11-06) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-11-06) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-full (2018-08-24) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-04-04) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-02-06) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-02-06) - TM01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-full (2017-01-16) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2017-05-04) - MR04
-
confirmation-statement-with-updates (2017-05-15) - CS01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-05-19) - MR01
-
memorandum-articles (2017-06-12) - MA
-
accounts-with-accounts-type-full (2017-11-30) - AA
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2017-12-01) - AA01
-
resolution (2017-06-12) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-04-21) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-04-18) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-04-12) - AP01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-full (2015-09-15) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-04-16) - AR01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2015-04-15) - TM02
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-04-09) - MR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-04-01) - TM01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2015-03-20) - MR04
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-02-18) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-02-18) - AP01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2015-02-18) - AP03
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-02-18) - AD01
-
certificate-change-of-name-company (2015-01-30) - CERTNM
-
change-of-name-notice (2015-01-30) - CONNOT
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2015-03-16) - AA01
keyboard_arrow_right 2014
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-03-31) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-03-31) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-05-27) - AP01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2014-07-12) - MR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-08-18) - AP01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2014-09-22) - AP03
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2014-12-22) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-08-18) - TM01
keyboard_arrow_right 2013
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-11-14) - AD01
-
certificate-change-of-name-company (2013-07-31) - CERTNM
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-05-09) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2013-05-09) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-05-09) - AD01
-
incorporation-company (2013-03-25) - NEWINC