-
PREMIER FLOORING AND FURNITURE LIMITED - 2-3 Winckley Court Chapel Street, Preston, PR1 8BU, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08456669
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 2-3 Winckley Court Chapel Street
- Preston
- PR1 8BU 2-3 Winckley Court Chapel Street, Preston, PR1 8BU UK
Management
- Geschäftsführung
- RAFIQ, Amjad
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 21.03.2013
- Gelöscht am:
- 2021-06-30
- SIC/NACE
- 46470
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Rafiq Estates Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2020-03-18
- Letzte Einreichung: 2018-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2020-04-04
- Letzte Einreichung: 2019-03-21
-
PREMIER FLOORING AND FURNITURE LIMITED Firmenbeschreibung
- PREMIER FLOORING AND FURNITURE LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08456669. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 21.03.2013 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "46470" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.03.2018 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 2-3 Winckley Court Chapel Street erreicht werden.
Jetzt sichern PREMIER FLOORING AND FURNITURE LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Premier Flooring And Furniture Limited - 2-3 Winckley Court Chapel Street, Preston, PR1 8BU, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu PREMIER FLOORING AND FURNITURE LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
liquidation-voluntary-creditors-return-of-final-meeting (2021-03-30) - LIQ14
-
gazette-dissolved-liquidation (2021-06-30) - GAZ2
keyboard_arrow_right 2020
-
second-filing-of-director-termination-with-name (2020-03-12) - RP04TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-03-04) - AD01
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2020-03-03) - LIQ02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-01-29) - TM01
-
resolution (2020-03-03) - RESOLUTIONS
-
change-person-director-company-with-change-date (2020-03-18) - CH01
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2020-03-03) - 600
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-03-28) - CS01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2019-12-18) - AA01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-09-13) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-04-04) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-12-20) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-03-30) - CH01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-27) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-03-27) - CH01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-12-23) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-11-21) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-11-21) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-05-06) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-03-25) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-01-09) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-12-11) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-04-11) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-04-22) - AP01
-
incorporation-company (2013-03-21) - NEWINC