-
ZONE RECOVERY GLOBAL LTD - Hillier Hopkins Llp First Floor Radius House, 51 Clarendon Road, Watford, Hertfordshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08444127
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Hillier Hopkins Llp First Floor Radius House
- 51 Clarendon Road
- Watford
- Hertfordshire
- WD17 1HP
- United Kingdom Hillier Hopkins Llp First Floor Radius House, 51 Clarendon Road, Watford, Hertfordshire, WD17 1HP, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- CORRIDAN, Michael
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 14.03.2013
- Alter der Firma 2013-03-14 11 Jahre
- SIC/NACE
- 43110
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- -
- Mr Michael Corridan
- Mr Nicholas Rodney Penfold
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- BESPOKE4 LTD.
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2023-12-30
- Letzte Einreichung: 2022-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2023-12-31
- Letzte Einreichung: 2022-12-17
-
ZONE RECOVERY GLOBAL LTD Firmenbeschreibung
- ZONE RECOVERY GLOBAL LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08444127. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 14.03.2013 registriert. ZONE RECOVERY GLOBAL LTD hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen BESPOKE4 LTD. ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "43110" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.03.2019 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Hillier Hopkins Llp First Floor Radius House erreicht werden.
Jetzt sichern ZONE RECOVERY GLOBAL LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Zone Recovery Global Ltd - Hillier Hopkins Llp First Floor Radius House, 51 Clarendon Road, Watford, Hertfordshire, Grossbritannien
- 2013-03-14
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu ZONE RECOVERY GLOBAL LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2023-03-15) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-06-15) - AA
-
change-to-a-person-with-significant-control (2023-01-06) - PSC04
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-01-05) - CS01
keyboard_arrow_right 2022
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-03-18) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-12-21) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2021-03-31) - AA
-
change-to-a-person-with-significant-control (2021-12-21) - PSC04
keyboard_arrow_right 2020
-
change-to-a-person-with-significant-control (2020-11-20) - PSC04
-
change-to-a-person-with-significant-control (2020-11-24) - PSC04
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-11-23) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2020-11-23) - PSC01
-
change-person-director-company-with-change-date (2020-11-20) - CH01
-
confirmation-statement-with-updates (2020-12-21) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-04-11) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-04-11) - TM01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-04-11) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-04-11) - PSC01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-06-12) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-06-12) - PSC01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-10-11) - AD01
-
capital-allotment-shares (2019-12-17) - SH01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-03-20) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-04-15) - AD01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-12-19) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2019-12-23) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-02-26) - AA
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-05-01) - PSC01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-05-17) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-07-11) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-07-11) - AP01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-07-11) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-07-11) - PSC01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-09-11) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-09-11) - TM01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-09-13) - PSC01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-09-13) - PSC07
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2018-12-24) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
resolution (2017-05-24) - RESOLUTIONS
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-05-24) - CH01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-07-14) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-06-10) - CH01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2016-12-20) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-06-02) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2015-12-31) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-06-22) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2014-12-12) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-06-10) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-04-12) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2013-04-12) - TM01
-
incorporation-company (2013-03-14) - NEWINC