-
AGRIAL FRESH FARMS LTD - Wood End Lane, Fradley, Lichfield, WS13 8NF, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08409499
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Wood End Lane
- Fradley
- Lichfield
- WS13 8NF
- England Wood End Lane, Fradley, Lichfield, WS13 8NF, England UK
Management
- Geschäftsführung
- DAVIES, Simon Peter
- FAUJOUR, Jean-Marc
- HAYAT, Dan Olivier
- NEVEU, Emmanuel Pascal
- ROBERTSON, Douglas Colin
- TOTEL, Bertrand Roger Joseph
- Prokuristen
- DAVIES, Simon Peter
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 19.02.2013
- Alter der Firma 2013-02-19 11 Jahre
- SIC/NACE
- 01130
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Agrial Fresh Produce Ltd
- Mr Ludovic Spiers
- Mr Arnaud Degoulet
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- ANGFLOR LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-09-30
- Letzte Einreichung: 2020-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-03-01
- Letzte Einreichung: 2021-02-15
-
AGRIAL FRESH FARMS LTD Firmenbeschreibung
- AGRIAL FRESH FARMS LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08409499. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 19.02.2013 registriert. AGRIAL FRESH FARMS LTD hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen ANGFLOR LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "01130" registriert. Das Unternehmen hat 6 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2020 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Wood End Lane erreicht werden.
Jetzt sichern AGRIAL FRESH FARMS LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Agrial Fresh Farms Ltd - Wood End Lane, Fradley, Lichfield, WS13 8NF, Grossbritannien
- 2013-02-19
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu AGRIAL FRESH FARMS LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2022
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2022-01-10) - AP01
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-full (2021-01-05) - AA
-
accounts-with-accounts-type-full (2021-10-08) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-02-15) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2020-10-07) - MR01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2020-06-23) - PSC01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-02-28) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
mortgage-satisfy-charge-full (2019-01-28) - MR04
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-01-29) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-01-29) - PSC02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-01-29) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2019-01-29) - TM02
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-01-29) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-01-29) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-03-12) - CS01
-
resolution (2019-03-14) - RESOLUTIONS
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-07-23) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-10-07) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2019-01-29) - AA01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2019-01-29) - AP03
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-10-25) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-05-04) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-03-06) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-03-28) - TM01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-09-11) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-31) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-11-08) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-08-03) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-10) - AR01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2016-02-26) - MR04
keyboard_arrow_right 2015
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-11-25) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-09-15) - AA
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2015-04-28) - AA01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-04-21) - MR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-03-18) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-03-05) - AR01
-
resolution (2014-06-24) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-09-29) - AA
-
capital-allotment-shares (2014-06-24) - SH01
keyboard_arrow_right 2013
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2013-08-02) - MR01
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2013-07-11) - AP03
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-07-11) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-07-08) - AD01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2013-02-19) - AA01
-
incorporation-company (2013-02-19) - NEWINC