-
2025 CREATIVE GROUP LIMITED - West Bush House Hailey Lane, Hailey, Hertford, SG13 7NY, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08400859
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- West Bush House Hailey Lane
- Hailey
- Hertford
- SG13 7NY West Bush House Hailey Lane, Hailey, Hertford, SG13 7NY UK
Management
- Geschäftsführung
- DUNLOP, Bruce Walter
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 13.02.2013
- Alter der Firma 2013-02-13 11 Jahre
- SIC/NACE
- 59112
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Bruce Dunlop
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Ehemalige Namen
- DUNLOP GOODRICH LTD
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2023-12-31
- Letzte Einreichung: 2022-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-02-27
- Letzte Einreichung: 2023-02-13
-
2025 CREATIVE GROUP LIMITED Firmenbeschreibung
- 2025 CREATIVE GROUP LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08400859. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 13.02.2013 registriert. 2025 CREATIVE GROUP LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen DUNLOP GOODRICH LTD ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "59112" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.03.2022 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über West Bush House Hailey Lane erreicht werden.
Jetzt sichern 2025 CREATIVE GROUP LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: 2025 Creative Group Limited - West Bush House Hailey Lane, Hailey, Hertford, SG13 7NY, Grossbritannien
- 2013-02-13
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu 2025 CREATIVE GROUP LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
dissolution-application-strike-off-company (2024-01-12) - DS01
keyboard_arrow_right 2023
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-01-04) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-02-21) - CS01
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-03-23) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-12-23) - AA
-
gazette-notice-compulsory (2021-06-08) - GAZ1
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-08-16) - CS01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2021-08-17) - DISS40
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-12-16) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-06-25) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-02-23) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-11-15) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2019-02-18) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-10-15) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-02-18) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
change-to-a-person-with-significant-control (2017-11-22) - PSC04
-
resolution (2017-11-21) - RESOLUTIONS
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-11-21) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2017-06-25) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-02-20) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-02-17) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-10-20) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-02-14) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-07-31) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-10-22) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-12-15) - AP01
-
capital-allotment-shares (2014-10-17) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-03-05) - AP01
-
capital-allotment-shares (2014-03-05) - SH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-03-03) - AR01
-
capital-cancellation-shares (2014-02-03) - SH06
-
capital-return-purchase-own-shares (2014-02-03) - SH03
-
resolution (2014-01-20) - RESOLUTIONS
-
capital-name-of-class-of-shares (2014-01-20) - SH08
-
capital-alter-shares-subdivision (2014-01-20) - SH02
keyboard_arrow_right 2013
-
resolution (2013-02-20) - RESOLUTIONS
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2013-11-29) - AA01
-
termination-director-company-with-name (2013-10-10) - TM01
-
incorporation-company (2013-02-13) - NEWINC
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-03-19) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-03-19) - AP01