-
NEWINCCO 1222 LIMITED - One, Gloucester Place, Brighton, BN1 4AA, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08388201
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- One
- Gloucester Place
- Brighton
- BN1 4AA One, Gloucester Place, Brighton, BN1 4AA UK
Management
- Geschäftsführung
- GUPTA, Viren
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 04.02.2013
- Gelöscht am:
- 2021-08-17
- SIC/NACE
- 70100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Andrew Jeremy Colin
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-07-01
- Letzte Einreichung: 2019-07-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-02-18
- Letzte Einreichung: 2021-02-04
-
NEWINCCO 1222 LIMITED Firmenbeschreibung
- NEWINCCO 1222 LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08388201. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 04.02.2013 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "70100" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.07.2019 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über One erreicht werden.
Jetzt sichern NEWINCCO 1222 LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Newincco 1222 Limited - One, Gloucester Place, Brighton, BN1 4AA, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu NEWINCCO 1222 LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
gazette-notice-voluntary (2021-06-01) - GAZ1(A)
-
gazette-dissolved-voluntary (2021-08-17) - GAZ2(A)
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-02-05) - CS01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2021-04-01) - AA01
-
dissolution-application-strike-off-company (2021-05-21) - DS01
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2020-04-28) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-02-04) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-05-01) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-05-01) - TM01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2019-03-25) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-02-06) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2018-04-27) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-02-09) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-01-31) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-02-22) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-04-10) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-01-31) - TM01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-04-13) - TM01
keyboard_arrow_right 2016
-
mortgage-satisfy-charge-full (2016-01-09) - MR04
-
accounts-amended-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-06-01) - AAMD
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-04-29) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-30) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-11-27) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-11-27) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-04-17) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-03-24) - AR01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2015-03-24) - TM02
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-07-09) - AR01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2014-07-12) - DISS40
-
gazette-notice-compulsary (2014-06-10) - GAZ1
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-12-17) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
resolution (2013-03-18) - RESOLUTIONS
-
incorporation-company (2013-02-04) - NEWINC
-
change-of-name-notice (2013-03-12) - CONNOT
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2013-03-18) - AA01
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-03-18) - AP01
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2013-03-18) - AP03
-
termination-director-company-with-name (2013-03-18) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name (2013-03-18) - TM02
-
legacy (2013-04-15) - MG01
-
legacy (2013-04-16) - MG01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-04-16) - AD01
-
capital-allotment-shares (2013-04-19) - SH01
-
mortgage-charge-part-release-with-charge-number (2013-07-05) - MR05
-
capital-allotment-shares (2013-03-18) - SH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-03-18) - AD01