-
WOOF AND BREW LIMITED - 4 Bramley Road, St. Ives, PE27 3WS, England, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08370145
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 4 Bramley Road
- St. Ives
- PE27 3WS
- England 4 Bramley Road, St. Ives, PE27 3WS, England UK
Management
- Geschäftsführung
- BENNETT, Stephen David
- MORTON, Lisa Jane
- WALKER, David Jonathan Haddon
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 22.01.2013
- Alter der Firma 2013-01-22 11 Jahre
- SIC/NACE
- 10920
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Stephen David Bennett
- Mr David Jonathan Haddon Walker
- Mrs Lisa Jane Morton
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-09-30
- Letzte Einreichung: 2022-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-05-24
- Letzte Einreichung: 2023-05-10
-
WOOF AND BREW LIMITED Firmenbeschreibung
- WOOF AND BREW LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08370145. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 22.01.2013 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "10920" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2022 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 4 Bramley Road erreicht werden.
Jetzt sichern WOOF AND BREW LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Woof And Brew Limited - 4 Bramley Road, St. Ives, PE27 3WS, England, Grossbritannien
- 2013-01-22
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu WOOF AND BREW LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2023-09-29) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-05-10) - CS01
keyboard_arrow_right 2022
-
mortgage-satisfy-charge-full (2022-03-14) - MR04
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-05-17) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2022-09-16) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-06-10) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2021-09-29) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
capital-allotment-shares (2020-06-08) - SH01
-
confirmation-statement-with-updates (2020-06-08) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2020-12-30) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-09-30) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2019-05-14) - CS01
-
capital-allotment-shares (2019-04-03) - SH01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-02-08) - CS01
-
capital-allotment-shares (2019-02-08) - SH01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-01-24) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
resolution (2018-12-03) - RESOLUTIONS
-
second-filing-capital-allotment-shares (2018-12-07) - RP04SH01
-
capital-alter-shares-subdivision (2018-11-29) - SH02
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-09-28) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-01-22) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-07-27) - PSC01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-09-29) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-02-03) - CS01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-12-08) - MR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-01-05) - AD01
keyboard_arrow_right 2016
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-04-07) - AP01
-
capital-allotment-shares (2016-11-07) - SH01
-
capital-alter-shares-subdivision (2016-11-07) - SH02
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-09-07) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-01-25) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-02-19) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-02-19) - AR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-04-30) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-09-30) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
termination-director-company-with-name (2014-03-31) - TM01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2014-03-28) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-03-28) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-02-07) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
capital-allotment-shares (2013-08-21) - SH01
-
resolution (2013-08-21) - RESOLUTIONS
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-11-27) - AD01
-
incorporation-company (2013-01-22) - NEWINC
-
capital-name-of-class-of-shares (2013-08-21) - SH08