-
PYTRONOT SERVICES LIMITED - Unit 3 Drove Road, Gamlingay, Sandy, Cambridgeshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08353013
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Unit 3 Drove Road
- Gamlingay
- Sandy
- Cambridgeshire
- SG19 2HX
- England Unit 3 Drove Road, Gamlingay, Sandy, Cambridgeshire, SG19 2HX, England UK
Management
- Geschäftsführung
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 09.01.2013
- Alter der Firma 2013-01-09 11 Jahre
- SIC/NACE
- 70229
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Gideon David Schulman
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active — Active proposal to strike off
- Ehemalige Namen
- MARYLAND BALTIMORE LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-09-30
- Letzte Einreichung: 2019-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2023-10-07
- Letzte Einreichung: 2022-09-23
-
PYTRONOT SERVICES LIMITED Firmenbeschreibung
- PYTRONOT SERVICES LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08353013. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 09.01.2013 registriert. PYTRONOT SERVICES LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen MARYLAND BALTIMORE LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "70229" registriert. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2019 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Unit 3 Drove Road erreicht werden.
Jetzt sichern PYTRONOT SERVICES LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Pytronot Services Limited - Unit 3 Drove Road, Gamlingay, Sandy, Cambridgeshire, Grossbritannien
- 2013-01-09
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu PYTRONOT SERVICES LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2023-01-09) - AD01
-
gazette-notice-compulsory (2023-06-27) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2022
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2022-04-25) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2022-09-05) - AD01
-
certificate-change-of-name-company (2022-05-12) - CERTNM
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2022-05-12) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2022-05-12) - AP01
-
certificate-change-of-name-company (2022-04-26) - CERTNM
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2022-04-25) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2022-09-08) - CS01
-
dissolution-withdrawal-application-strike-off-company (2022-04-13) - DS02
-
confirmation-statement-with-updates (2022-09-23) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
gazette-notice-voluntary (2021-07-06) - GAZ1(A)
-
dissolution-application-strike-off-company (2021-06-28) - DS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2021-05-13) - PSC01
-
withdrawal-of-a-person-with-significant-control-statement (2021-05-06) - PSC09
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-05-05) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-05-05) - TM01
-
dissolution-voluntary-strike-off-suspended (2021-08-05) - SOAS(A)
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-updates (2020-10-05) - CS01
-
confirmation-statement-with-updates (2020-02-20) - CS01
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2020-01-11) - DISS16(SOAS)
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2020-02-01) - DISS40
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-01-30) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-12-23) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
gazette-notice-compulsory (2019-12-10) - GAZ1
-
confirmation-statement-with-updates (2019-01-07) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-09-28) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-01-23) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2017-09-29) - AA
-
capital-allotment-shares (2017-07-11) - SH01
-
resolution (2017-03-30) - RESOLUTIONS
-
confirmation-statement-with-updates (2017-02-13) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2016-10-31) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-05) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-07-24) - AD01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-07-09) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-02-20) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-01-09) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2014-10-09) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-02-20) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2014-01-22) - AD01
keyboard_arrow_right 2013
-
incorporation-company (2013-01-09) - NEWINC