-
HARRISON C WHITE LIMITED - Jupiter House Warley Hill Business Park, The Drive, Brentwood, Essex, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08351666
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Jupiter House Warley Hill Business Park
- The Drive
- Brentwood
- Essex
- CM13 3BE Jupiter House Warley Hill Business Park, The Drive, Brentwood, Essex, CM13 3BE UK
Management
- Geschäftsführung
- DAY, Carl Peter John
- GVASALIIA, Inga Valerianovna
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 08.01.2013
- Alter der Firma 2013-01-08 11 Jahre
- SIC/NACE
- 70229
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Carl Peter John Day
- Ms Emma Louise Gammons
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Liquidation
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2019-03-31
- Letzte Einreichung: 2016-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2020-01-22
- Letzte Einreichung: 2019-01-08
-
HARRISON C WHITE LIMITED Firmenbeschreibung
- HARRISON C WHITE LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08351666. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 08.01.2013 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "70229" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2016 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Jupiter House Warley Hill Business Park erreicht werden.
Jetzt sichern HARRISON C WHITE LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Harrison C White Limited - Jupiter House Warley Hill Business Park, The Drive, Brentwood, Essex, Grossbritannien
- 2013-01-08
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu HARRISON C WHITE LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
liquidation-voluntary-creditors-return-of-final-meeting (2024-01-24) - LIQ14
keyboard_arrow_right 2023
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2023-06-20) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2022
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2022-07-19) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2020
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2020-08-03) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2019
-
mortgage-satisfy-charge-part (2019-04-01) - MR04
-
mortgage-satisfy-charge-full (2019-04-01) - MR04
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2019-05-08) - TM02
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-01-18) - CS01
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2019-06-10) - 600
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2019-06-10) - LIQ02
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-06-11) - AD01
-
resolution (2019-06-10) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2018
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-12-21) - PSC01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-11-20) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-11-20) - AP01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2018-11-06) - AP03
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2018-09-26) - AA01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-01-18) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-12-21) - PSC04
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-group (2017-12-15) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2017-11-29) - DISS40
-
gazette-notice-compulsory (2017-11-28) - GAZ1
-
resolution (2017-03-03) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2017-02-21) - SH01
-
capital-name-of-class-of-shares (2017-02-21) - SH08
-
confirmation-statement-with-updates (2017-01-20) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-10-04) - TM01
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company (2016-01-21) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-03-21) - AD01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2016-06-14) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-02-17) - AA
-
accounts-with-accounts-type-group (2016-10-19) - AA
-
capital-allotment-shares (2016-12-07) - SH01
-
second-filing-of-annual-return-with-made-up-date (2016-12-13) - RP04AR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-08-30) - AP01
keyboard_arrow_right 2015
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-11-06) - AP01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-07-23) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-07-22) - MR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-02-20) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-02-19) - CH01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2014-08-18) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-01-09) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
incorporation-company (2013-01-08) - NEWINC