-
CORE DISPLAYS LTD - 17 Napier Court, Off Gander Lane, Chesterfield, Derbyshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08332144
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 17 Napier Court
- Off Gander Lane
- Chesterfield
- Derbyshire
- S43 4PZ 17 Napier Court, Off Gander Lane, Chesterfield, Derbyshire, S43 4PZ UK
Management
- Geschäftsführung
- DYE, Andrew John
- FOTHERGILL, Wayne Ian
- WALKER, Marc Anthony
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 14.12.2012
- Alter der Firma 2012-12-14 11 Jahre
- SIC/NACE
- 18129
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Andrew John Dye
- Mr Wayne Ian Fothergill
- Mr Marc Anthony Walker
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-10-31
- Letzte Einreichung: 2023-01-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2023-12-28
- Letzte Einreichung: 2022-12-14
-
CORE DISPLAYS LTD Firmenbeschreibung
- CORE DISPLAYS LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08332144. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 14.12.2012 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "18129" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über 17 Napier Court erreicht werden.
Jetzt sichern CORE DISPLAYS LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Core Displays Ltd - 17 Napier Court, Off Gander Lane, Chesterfield, Derbyshire, Grossbritannien
- 2012-12-14
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu CORE DISPLAYS LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
change-person-director-company-with-change-date (2023-12-20) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2023-07-26) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2023-12-12) - CH01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2023-12-12) - PSC04
-
change-to-a-person-with-significant-control (2023-12-13) - PSC04
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-updates (2022-01-04) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2022-01-04) - CH01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2022-01-04) - PSC04
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2022-11-07) - AA
-
change-to-a-person-with-significant-control (2022-01-05) - PSC04
-
confirmation-statement-with-updates (2022-12-14) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2021-10-29) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-01-21) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2020-10-30) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2019-10-15) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-12-19) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-12-19) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-12-19) - PSC04
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-12-19) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2018-06-21) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-12-19) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-08-07) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-12-16) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-12-16) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-05-23) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-04-07) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-01-12) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-10-20) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-01-12) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
capital-allotment-shares (2014-02-17) - SH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-09-12) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2014-09-11) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-02-18) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-02-17) - AP01
keyboard_arrow_right 2012
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-12-19) - AP01
-
incorporation-company (2012-12-14) - NEWINC
-
termination-director-company-with-name (2012-12-19) - TM01