-
CRABTREE WHARF LIMITED - The Old Town Hall, 71 Christchurch Road, Ringwood, BH24 1DH, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08320516
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- The Old Town Hall
- 71 Christchurch Road
- Ringwood
- BH24 1DH The Old Town Hall, 71 Christchurch Road, Ringwood, BH24 1DH UK
Management
- Geschäftsführung
- BROMWICH, John Frederick
- KELLY, Dermot Francis
- WELSH, Andrew Mcclure
- Prokuristen
- BROMWICH, John Frederick
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 06.12.2012
- Alter der Firma 2012-12-06 11 Jahre
- SIC/NACE
- 41100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Greenhill Corner Ltd
- Greenhill Corner Ltd
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- liquidation
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-09-30
- Letzte Einreichung: 2019-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-12-20
- Letzte Einreichung: 2020-12-06
-
CRABTREE WHARF LIMITED Firmenbeschreibung
- CRABTREE WHARF LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08320516. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 06.12.2012 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "41100" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2019 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über The Old Town Hall erreicht werden.
Jetzt sichern CRABTREE WHARF LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Crabtree Wharf Limited - The Old Town Hall, 71 Christchurch Road, Ringwood, BH24 1DH, Grossbritannien
- 2012-12-06
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu CRABTREE WHARF LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
mortgage-satisfy-charge-full (2021-03-19) - MR04
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-05-11) - AD01
-
liquidation-voluntary-declaration-of-solvency (2021-06-01) - LIQ01
-
resolution (2021-06-01) - RESOLUTIONS
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2021-06-01) - 600
keyboard_arrow_right 2020
-
second-filing-capital-allotment-shares (2020-08-06) - RP04SH01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-02-10) - TM01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-02-07) - TM01
-
capital-allotment-shares (2020-01-29) - SH01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-02-14) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-06-15) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-03-10) - TM01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-02-17) - TM01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-03-09) - TM01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-03-03) - TM01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2020-12-20) - PSC03
-
confirmation-statement-with-updates (2020-12-20) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2020-07-25) - PSC02
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-07-19) - PSC07
keyboard_arrow_right 2019
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-12-10) - PSC01
-
withdrawal-of-a-person-with-significant-control-statement (2019-12-10) - PSC09
-
confirmation-statement-with-updates (2019-12-07) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-08-01) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2019-08-01) - MR04
keyboard_arrow_right 2018
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-05-29) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-07-04) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-12-10) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-small (2017-05-22) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-12-14) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-12-09) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-06-24) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-12-10) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-12-10) - CH01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2015-09-12) - MR04
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-09-01) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-08-15) - MR01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2015-07-09) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-06-19) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-12-12) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-07-04) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-01-10) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
change-person-director-company-with-change-date (2013-01-04) - CH01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2013-01-19) - CH03
-
capital-allotment-shares (2013-01-28) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-01-28) - AP01
-
resolution (2013-01-31) - RESOLUTIONS
-
legacy (2013-02-01) - MG01
keyboard_arrow_right 2012
-
incorporation-company (2012-12-06) - NEWINC