-
AMISTHA BIDCO LIMITED - 110 Wigmore Street, Marylebone, London, W1U 3RW, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08312827
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 110 Wigmore Street
- Marylebone
- London
- W1U 3RW 110 Wigmore Street, Marylebone, London, W1U 3RW UK
Management
- Geschäftsführung
- SANDERS, Richard Barry
- TAMBERLIN, Layton Gwyn
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 29.11.2012
- Alter der Firma 2012-11-29 11 Jahre
- SIC/NACE
- 70100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Layton Gwyn Tamberlin
- Mr Richard Barry Sanders
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-03-31
- Letzte Einreichung: 2019-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-12-13
- Letzte Einreichung: 2020-11-29
-
AMISTHA BIDCO LIMITED Firmenbeschreibung
- AMISTHA BIDCO LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08312827. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 29.11.2012 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "70100" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über 110 Wigmore Street erreicht werden.
Jetzt sichern AMISTHA BIDCO LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Amistha Bidco Limited - 110 Wigmore Street, Marylebone, London, W1U 3RW, Grossbritannien
- 2012-11-29
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu AMISTHA BIDCO LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-02-16) - CS01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2021-01-29) - DISS40
-
accounts-with-accounts-type-full (2021-11-15) - AA
-
gazette-notice-compulsory (2021-01-19) - GAZ1
-
gazette-notice-compulsory (2021-05-04) - GAZ1
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2021-06-18) - DISS16(SOAS)
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-01-09) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-03-16) - TM01
keyboard_arrow_right 2019
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-10-29) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-03-28) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-small (2019-01-03) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
mortgage-satisfy-charge-full (2018-06-01) - MR04
-
resolution (2018-07-31) - RESOLUTIONS
-
legacy (2018-07-31) - CAP-SS
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-06-06) - MR01
-
legacy (2018-07-31) - SH20
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-08-23) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-09-03) - AD01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-12-13) - CS01
-
capital-statement-capital-company-with-date-currency-figure (2018-07-31) - SH19
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-11-29) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-small (2017-08-07) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-full (2016-12-17) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-11-29) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-05-03) - TM01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-full (2015-12-31) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-12-17) - AR01
-
auditors-resignation-company (2015-10-16) - AUD
-
mortgage-satisfy-charge-full (2015-03-27) - MR04
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-02-19) - CH01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2015-03-26) - MR04
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-03-11) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-full (2015-01-07) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-full (2014-01-02) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-12-01) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
legacy (2013-02-07) - MG01
-
legacy (2013-02-13) - MG01
-
termination-secretary-company-with-name (2013-01-30) - TM02
-
capital-allotment-shares (2013-02-13) - SH01
-
capital-allotment-shares (2013-02-14) - SH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-12-09) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-02-13) - AD01
keyboard_arrow_right 2012
-
resolution (2012-12-21) - RESOLUTIONS
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-12-05) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2012-12-05) - TM01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2012-12-05) - AA01
-
incorporation-company (2012-11-29) - NEWINC