-
FULCRUM POWER GENERATION LIMITED - 3rd Floor, 141-145 Curtain Road, London, EC2A 3BX, England, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08295779
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 3rd Floor, 141-145 Curtain Road
- London
- EC2A 3BX
- England 3rd Floor, 141-145 Curtain Road, London, EC2A 3BX, England UK
Management
- Geschäftsführung
- CHAMBERLAYNE, Robin Francis
- NEWMAN, Andrew Jonathan Charles
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 15.11.2012
- Gelöscht am:
- 2021-06-01
- SIC/NACE
- 35110
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Mr Robin Francis Chamberlayne
- -
- -
- -
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-11-30
- Letzte Einreichung: 2020-02-28
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-11-29
- Letzte Einreichung: 2020-11-15
-
FULCRUM POWER GENERATION LIMITED Firmenbeschreibung
- FULCRUM POWER GENERATION LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08295779. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 15.11.2012 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "35110" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 28.02.2020 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 3Rd Floor, 141-145 Curtain Road erreicht werden.
Jetzt sichern FULCRUM POWER GENERATION LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Fulcrum Power Generation Limited - 3rd Floor, 141-145 Curtain Road, London, EC2A 3BX, England, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu FULCRUM POWER GENERATION LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
gazette-dissolved-voluntary (2021-06-01) - GAZ2(A)
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2021-02-19) - AA
-
dissolution-application-strike-off-company (2021-03-09) - DS01
-
gazette-notice-voluntary (2021-03-16) - GAZ1(A)
keyboard_arrow_right 2020
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2020-12-17) - TM02
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-12-16) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-12-16) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2020-11-27) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-09-16) - AD01
keyboard_arrow_right 2019
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-02-22) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2019-11-28) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2019-11-25) - CS01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2019-02-25) - CH03
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-11-19) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2018-11-19) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2017-12-06) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-11-20) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2017-11-10) - PSC04
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2017-11-10) - PSC07
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-09-29) - TM01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2017-09-18) - PSC07
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-11-30) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-11-24) - CS01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-12-31) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-12-01) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-08-19) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-01-08) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2014-02-03) - AA01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2014-02-26) - CH03
-
resolution (2014-05-09) - RESOLUTIONS
-
legacy (2014-05-09) - CAP-SS
-
legacy (2014-05-09) - SH20
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-02-04) - CH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2014-05-16) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-08-15) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2014-09-17) - AD01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2014-09-23) - AD01
-
capital-statement-capital-company-with-date-currency-figure (2014-05-16) - SH19
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-12-13) - AR01
-
capital-allotment-shares (2013-09-05) - SH01
-
capital-allotment-shares (2013-09-02) - SH01
-
capital-allotment-shares (2013-05-08) - SH01
-
resolution (2013-04-19) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2013-02-15) - SH01
-
capital-allotment-shares (2013-01-16) - SH01
-
resolution (2013-01-04) - RESOLUTIONS
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-01-04) - AP01
keyboard_arrow_right 2012
-
incorporation-company (2012-11-15) - NEWINC