-
APPLIED DESIGN CONSTRUCTION LIMITED - 311 High Road, Loughton, Essex, IG10 1AH, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08291986
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 311 High Road
- Loughton
- Essex
- IG10 1AH 311 High Road, Loughton, Essex, IG10 1AH UK
Management
- Geschäftsführung
- CONDON, Eamon
- CONDON, Frank Charles
- HAMMOND, Adam Montague
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 13.11.2012
- Alter der Firma 2012-11-13 11 Jahre
- SIC/NACE
- 41202
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr. Frank Charles Condon
- Mr Eamon Condon
- Mr. Adam Montague Hammond
- Mr Eamon Condon
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- liquidation
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2018-12-31
- Letzte Einreichung: 2017-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2017-11-27
- Letzte Einreichung: 2016-11-13
-
APPLIED DESIGN CONSTRUCTION LIMITED Firmenbeschreibung
- APPLIED DESIGN CONSTRUCTION LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08291986. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 13.11.2012 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "41202" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über 311 High Road erreicht werden.
Jetzt sichern APPLIED DESIGN CONSTRUCTION LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Applied Design Construction Limited - 311 High Road, Loughton, Essex, IG10 1AH, Grossbritannien
- 2012-11-13
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu APPLIED DESIGN CONSTRUCTION LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2020-12-02) - LIQ03
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2020-04-29) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2018-01-08) - AA
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2018-12-06) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2017
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-10-06) - AD01
-
liquidation-voluntary-declaration-of-solvency (2017-10-04) - LIQ01
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2017-10-04) - 600
-
resolution (2017-10-04) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-01-11) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-11-21) - CH01
-
confirmation-statement-with-updates (2016-11-18) - CS01
keyboard_arrow_right 2015
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-04-27) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-12-02) - AR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-11-25) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-08-14) - AA
-
capital-cancellation-shares (2015-04-30) - SH06
-
capital-return-purchase-own-shares (2015-04-30) - SH03
keyboard_arrow_right 2014
-
capital-allotment-shares (2014-11-29) - SH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-11-29) - AR01
-
second-filing-of-form-with-form-type-made-up-date (2014-09-17) - RP04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-09-08) - AA
-
capital-allotment-shares (2014-07-30) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-07-30) - AP01
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2014-07-08) - AA01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2014-07-08) - AD01
-
capital-allotment-shares (2014-01-06) - SH01
keyboard_arrow_right 2013
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2013-11-27) - MR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-11-15) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-10-10) - AP01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2013-10-10) - MR01
keyboard_arrow_right 2012
-
incorporation-company (2012-11-13) - NEWINC