-
DBS MUSIC HOLDINGS LIMITED - 26 Hulme Street, Manchester, Greater Manchester, M1 5BW, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08288829
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 26 Hulme Street
- Manchester
- Greater Manchester
- M1 5BW
- England 26 Hulme Street, Manchester, Greater Manchester, M1 5BW, England UK
Management
- Geschäftsführung
- BEAUMONT, Jason William
- SMITH, Paul David
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 12.11.2012
- Alter der Firma 2012-11-12 11 Jahre
- SIC/NACE
- 85320
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Dbs Music Uk Holdings Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2025-04-30
- Letzte Einreichung: 2023-07-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-03-24
- Letzte Einreichung: 2023-03-10
-
DBS MUSIC HOLDINGS LIMITED Firmenbeschreibung
- DBS MUSIC HOLDINGS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08288829. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 12.11.2012 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "85320" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über 26 Hulme Street erreicht werden.
Jetzt sichern DBS MUSIC HOLDINGS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Dbs Music Holdings Limited - 26 Hulme Street, Manchester, Greater Manchester, M1 5BW, Grossbritannien
- 2012-11-12
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu DBS MUSIC HOLDINGS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
accounts-with-accounts-type-small (2024-01-30) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2024-02-12) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2024-04-10) - AD01
keyboard_arrow_right 2023
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2023-01-05) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-03-13) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-small (2023-04-26) - AA
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-updates (2022-03-21) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-04-28) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2022-07-01) - MR01
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-updates (2021-03-10) - CS01
-
memorandum-articles (2021-08-03) - MA
-
resolution (2021-08-03) - RESOLUTIONS
-
memorandum-articles (2021-08-21) - MA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-08-12) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-04-30) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-08-12) - TM01
-
resolution (2021-08-21) - RESOLUTIONS
-
resolution (2021-09-17) - RESOLUTIONS
-
memorandum-articles (2021-09-17) - MA
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-12-09) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-04-03) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-07-01) - AD01
-
withdrawal-of-a-person-with-significant-control-statement (2019-11-14) - PSC09
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-11-14) - PSC02
-
confirmation-statement-with-updates (2019-12-02) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-updates (2018-12-14) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-09-06) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2018-08-14) - MR04
-
resolution (2018-08-01) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-02-16) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-04-26) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-09-14) - CH01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-12-12) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-11-22) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-04-29) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-12-04) - AR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-07-13) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-04-30) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-12-09) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-04-24) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-12-09) - AR01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2013-02-05) - AA01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-01-29) - AD01
-
capital-allotment-shares (2013-03-05) - SH01
keyboard_arrow_right 2012
-
incorporation-company (2012-11-12) - NEWINC