-
RYPC HOLDINGS LIMITED - Coulman Road Industrial Estate, Thorne, Doncaster, South Yorkshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08277356
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Coulman Road Industrial Estate
- Thorne
- Doncaster
- South Yorkshire
- DN8 5JS Coulman Road Industrial Estate, Thorne, Doncaster, South Yorkshire, DN8 5JS UK
Management
- Geschäftsführung
- DAVIES, Robert Andrew
- PAYNE, Charles Robert
- SIMMONDS, Paul Stuart
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 01.11.2012
- Alter der Firma 2012-11-01 11 Jahre
- SIC/NACE
- 10890
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Go2 Foods Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-12-31
- Letzte Einreichung: 2021-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-11-15
- Letzte Einreichung: 2021-11-01
-
RYPC HOLDINGS LIMITED Firmenbeschreibung
- RYPC HOLDINGS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08277356. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 01.11.2012 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "10890" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.03.2021 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Coulman Road Industrial Estate erreicht werden.
Jetzt sichern RYPC HOLDINGS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Rypc Holdings Limited - Coulman Road Industrial Estate, Thorne, Doncaster, South Yorkshire, Grossbritannien
- 2012-11-01
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu RYPC HOLDINGS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-12-06) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-small (2021-12-20) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-small (2020-12-17) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-11-13) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-11-15) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-small (2019-01-03) - AA
-
accounts-with-accounts-type-small (2019-12-10) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-11-01) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-small (2018-01-08) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-11-03) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-full (2017-01-06) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
capital-statement-capital-company-with-date-currency-figure (2016-05-12) - SH19
-
confirmation-statement-with-updates (2016-11-14) - CS01
-
legacy (2016-05-12) - SH20
-
legacy (2016-04-20) - CAP-SS
-
resolution (2016-04-20) - RESOLUTIONS
-
auditors-resignation-company (2016-01-11) - AUD
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-01-04) - MR01
keyboard_arrow_right 2015
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-12-23) - AP01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2015-12-23) - TM02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-12-23) - TM01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-12-02) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2015-12-02) - TM02
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-11-23) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-group (2015-06-22) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-group (2014-08-08) - AA
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2014-09-05) - TM02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-09-05) - TM01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2014-09-05) - AP03
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-09-05) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-11-05) - AR01
-
accounts-amended-with-accounts-type-group (2014-11-07) - AAMD
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-11-01) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2012-12-06) - AA01
-
resolution (2012-11-28) - RESOLUTIONS
-
incorporation-company (2012-11-01) - NEWINC
-
capital-allotment-shares (2012-11-28) - SH01